COMPASS RESIDENTIAL HOMES LTD

COMPASS RESIDENTIAL HOMES LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOMPASS RESIDENTIAL HOMES LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04022451
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COMPASS RESIDENTIAL HOMES LTD?

    • Strutture residenziali di assistenza per persone con difficoltà di apprendimento, disturbi mentali e abuso di sostanze (87200) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova COMPASS RESIDENTIAL HOMES LTD?

    Indirizzo della sede legale
    121 Abbs Cross Lane
    RM12 4XR Hornchurch
    Essex
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di COMPASS RESIDENTIAL HOMES LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per COMPASS RESIDENTIAL HOMES LTD?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per COMPASS RESIDENTIAL HOMES LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015

    9 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 143 Main Road Romford Essex RM2 6LS a 121 Abbs Cross Lane Hornchurch Essex RM12 4XR in data 21 ott 2015

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Christopher Paul Davis come amministratore in data 14 ago 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Enid June Sophia Pendergast come amministratore in data 14 ago 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sharon Davis come amministratore in data 14 ago 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 22 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 lug 2015

    Stato del capitale al 03 lug 2015

    • Capitale: GBP 10
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2014

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 giu 2014

    Stato del capitale al 26 giu 2014

    • Capitale: GBP 10
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2012

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2010

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Enid June Sophia Pendergast il 22 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Sharon Davis il 22 giu 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2009

    8 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2008

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di COMPASS RESIDENTIAL HOMES LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIS, Chris
    143 Main Road
    RM2 6LS Romford
    Essex
    Segretario
    143 Main Road
    RM2 6LS Romford
    Essex
    British70722230001
    DAVIS, Christopher Paul
    Abbs Cross Lane
    RM12 4XR Hornchurch
    121
    Essex
    England
    Amministratore
    Abbs Cross Lane
    RM12 4XR Hornchurch
    121
    Essex
    England
    United KingdomBritish200202480001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Segretario nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900015000001
    DAVIS, Sharon
    143 Main Road
    RM2 6LS Romford
    Essex
    Amministratore
    143 Main Road
    RM2 6LS Romford
    Essex
    United KingdomBritish70722250003
    PENDERGAST, Enid June Sophia
    Merton Court
    The Strand Brighton Marina Village
    BN2 5XY Brighton
    13
    East Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Merton Court
    The Strand Brighton Marina Village
    BN2 5XY Brighton
    13
    East Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritish70870780002
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Amministratore delegato nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900014990001

    COMPASS RESIDENTIAL HOMES LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 04 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    90 abbs cross lane hornchurch t/n NGL190295,. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 04 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    92 abbs cross lane hornchurch t/n EGL36945,. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 04 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    121 abbs cross lane hornchurch t/n EGL243654,. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 24 nov 2001
    Consegnato il 05 dic 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as 90 abbs cross elm lane hornchurch title number NGL190295. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 24 nov 2001
    Consegnato il 05 dic 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as 121 abbs cross lane elm lane hornchurch title number EGL243654. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 17 nov 2000
    Consegnato il 24 nov 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 90 abbs cross lane hornchurch essex.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 17 nov 2000
    Consegnato il 21 nov 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 121 abbs cross lane elm park hornchurch essex.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 06 set 2000
    Consegnato il 13 set 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 92 abbs cross lane elm park hornchurch essex. T/no. EGL36945. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 set 2000
    Consegnato il 07 set 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0