PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
Panoramica
Nome della società | PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04023094 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
- Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. (10890) / Industrie manifatturiere
Dove si trova PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
GATORADE LIMITED | 19 ott 2006 | 19 ott 2006 |
WALKERS INTERMEDIATE HOLDING COMPANY LIMITED | 26 set 2002 | 26 set 2002 |
GOLDEN WONDER FINANCE LIMITED | 27 lug 2000 | 27 lug 2000 |
DE FACTO 857 LIMITED | 28 giu 2000 | 28 giu 2000 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 29 dic 2012 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 17 set 2014
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 20 ago 2014
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Consolidamento delle azioni al 20 ago 2014 | 5 pagine | SH02 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 21 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di Claire Ellen Stone come amministratore in data 17 apr 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di John L Sigalos come amministratore in data 17 apr 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Nomina di Sharon Julie Dean come segretario in data 04 nov 2013 | 1 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Anwar Yaseen Ahmed come segretario in data 04 nov 2013 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 29 dic 2012 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 lug 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Nomina di Anwar Yaseen Ahmed come segretario in data 07 mar 2013 | 1 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Sharon Julie Dean come segretario in data 07 mar 2013 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
Nomina di Mr John L Sigalos come amministratore in data 07 set 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 lug 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Victoria Elizabeth Evans il 27 apr 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAN, Sharon Julie | Segretario | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | 182647960001 | |||||||
AVERISS, Joanne Kerry | Amministratore | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | England | British | Vp Law | 57057370001 | ||||
EVANS, Victoria Elizabeth | Amministratore | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | England | British | Solicitor | 103389550003 | ||||
STONE, Claire Ellen | Amministratore | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | England | British | Finance Director And Chartered Accountant | 111950160001 | ||||
AHMED, Anwar Yaseen | Segretario | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | 176432560001 | |||||||
AHMED, Anwar Yaseen | Segretario | 2 St Johns Road Tackley OX5 3AP Kidlington Oxfordshire | British | 96045380002 | ||||||
BOYD, Stephen Alexander | Segretario | Church Lane LE15 8EY Edith Weston 12 Rutland | British | Finance Director | 142394800001 | |||||
DEAN, Sharon Julie | Segretario | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | 148279850002 | |||||||
WILLIAMS, Mark | Segretario | 6 Setter Combe RG42 2FD Warfield Berkshire | British | Financial Controller | 76155240003 | |||||
TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 900006100001 | |||||||
AMIN, Salman | Amministratore | 25 Marlborough Place St John's Wood NW8 0PG London | Usa | President Pepsico Uk & Ireland | 116417620001 | |||||
BOYD, Stephen Alexander | Amministratore | Church Lane LE15 8EY Edith Weston 12 Rutland | England | British | Finance Director | 142394800001 | ||||
FRASER, Stanley Walter | Amministratore | 48 Grovewood Close WD3 5PX Chorleywood Hertfordshire | British | Corporate Vice President | 68204280001 | |||||
GLENN, Martin Richard | Amministratore | Manor House Stanford Dingley RG7 6LS Reading Berkshire | Uk | British | President | 61897350002 | ||||
HAMPTON, Anthony Nicholas Seymour | Amministratore | 1 High Close The Drive WD3 4DZ Rickmansworth Hertfordshire | United Kingdom | British | Vice President Operations | 77901460001 | ||||
KARLSSON, Tommy Harry Vilhelm | Amministratore | 15 Rue Lebouteux FOREIGN Paris 75017 France | Sweden | Swedish | Director | 116317060002 | ||||
SHARPE, Clive Richard | Amministratore | Knighton Rise LE2 2RE Leicester 18 Leics | England | British | Director | 134995270001 | ||||
SIGALOS, John L | Amministratore | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | United Kingdom | American | Chief Financial Officer | 170690380001 | ||||
SIMPSON DENT, Jonathan | Amministratore | 78 Hotham Road Putney SW15 1QP London | British | Chief Financial Officer | 110396210001 | |||||
VAN DER EEMS, Jeffrey Peter | Amministratore | 72 Stanley Road East Sheen SW14 7DZ London | England | British | Chief Financial Officer | 118890890001 | ||||
WILLIAMS, Mark | Amministratore | 6 Setter Combe RG42 2FD Warfield Berkshire | British | Financial Controller | 76155240003 | |||||
TRAVERS SMITH LIMITED | Amministratore delegato nominato | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 900006090001 | |||||||
TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 900006100001 |
PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture dated 29 july 2000 as amended and restated on 11 august 2000 by a composite restatement agreement dated 10 august 2000 (the "debenture") issued by the company | Creato il 11 ago 2000 Consegnato il 16 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito In favour of the chargee all money or liabilities due owing or incurred to any secured party by the charging company or any other charging company under the debenture or any other obligor under any finance document in whatsoever manner | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 29 lug 2000 Consegnato il 02 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein and each of the other obligors under the debenture and under any finance document to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0