PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04023094
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    • Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. (10890) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GATORADE LIMITED19 ott 200619 ott 2006
    WALKERS INTERMEDIATE HOLDING COMPANY LIMITED26 set 200226 set 2002
    GOLDEN WONDER FINANCE LIMITED27 lug 200027 lug 2000
    DE FACTO 857 LIMITED28 giu 200028 giu 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 17 set 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share prem acct 15/09/2014
    RES13

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 20 ago 2014

    • Capitale: GBP 93,757,033
    4 pagineSH01

    Consolidamento delle azioni al 20 ago 2014

    5 pagineSH02

    Risoluzioni

    Resolutions
    21 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Consolidated shares 20/08/2014
    RES13

    Nomina di Claire Ellen Stone come amministratore in data 17 apr 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John L Sigalos come amministratore in data 17 apr 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 11 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Sharon Julie Dean come segretario in data 04 nov 2013

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Anwar Yaseen Ahmed come segretario in data 04 nov 2013

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 29 dic 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Anwar Yaseen Ahmed come segretario in data 07 mar 2013

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Sharon Julie Dean come segretario in data 07 mar 2013

    1 pagineTM02

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Nomina di Mr John L Sigalos come amministratore in data 07 set 2012

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Victoria Elizabeth Evans il 27 apr 2012

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DEAN, Sharon Julie
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Segretario
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    182647960001
    AVERISS, Joanne Kerry
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    EnglandBritishVp Law57057370001
    EVANS, Victoria Elizabeth
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    EnglandBritishSolicitor103389550003
    STONE, Claire Ellen
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director And Chartered Accountant111950160001
    AHMED, Anwar Yaseen
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Segretario
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    176432560001
    AHMED, Anwar Yaseen
    2 St Johns Road
    Tackley
    OX5 3AP Kidlington
    Oxfordshire
    Segretario
    2 St Johns Road
    Tackley
    OX5 3AP Kidlington
    Oxfordshire
    British96045380002
    BOYD, Stephen Alexander
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    Segretario
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    BritishFinance Director142394800001
    DEAN, Sharon Julie
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Segretario
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    148279850002
    WILLIAMS, Mark
    6 Setter Combe
    RG42 2FD Warfield
    Berkshire
    Segretario
    6 Setter Combe
    RG42 2FD Warfield
    Berkshire
    BritishFinancial Controller76155240003
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Segretario nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    AMIN, Salman
    25 Marlborough Place
    St John's Wood
    NW8 0PG London
    Amministratore
    25 Marlborough Place
    St John's Wood
    NW8 0PG London
    UsaPresident Pepsico Uk & Ireland116417620001
    BOYD, Stephen Alexander
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    Amministratore
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    EnglandBritishFinance Director142394800001
    FRASER, Stanley Walter
    48 Grovewood Close
    WD3 5PX Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    48 Grovewood Close
    WD3 5PX Chorleywood
    Hertfordshire
    BritishCorporate Vice President68204280001
    GLENN, Martin Richard
    Manor House
    Stanford Dingley
    RG7 6LS Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Manor House
    Stanford Dingley
    RG7 6LS Reading
    Berkshire
    UkBritishPresident61897350002
    HAMPTON, Anthony Nicholas Seymour
    1 High Close
    The Drive
    WD3 4DZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 High Close
    The Drive
    WD3 4DZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishVice President Operations77901460001
    KARLSSON, Tommy Harry Vilhelm
    15 Rue Lebouteux
    FOREIGN Paris
    75017
    France
    Amministratore
    15 Rue Lebouteux
    FOREIGN Paris
    75017
    France
    SwedenSwedishDirector116317060002
    SHARPE, Clive Richard
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    Amministratore
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    EnglandBritishDirector134995270001
    SIGALOS, John L
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    United KingdomAmericanChief Financial Officer170690380001
    SIMPSON DENT, Jonathan
    78 Hotham Road
    Putney
    SW15 1QP London
    Amministratore
    78 Hotham Road
    Putney
    SW15 1QP London
    BritishChief Financial Officer110396210001
    VAN DER EEMS, Jeffrey Peter
    72 Stanley Road
    East Sheen
    SW14 7DZ London
    Amministratore
    72 Stanley Road
    East Sheen
    SW14 7DZ London
    EnglandBritishChief Financial Officer118890890001
    WILLIAMS, Mark
    6 Setter Combe
    RG42 2FD Warfield
    Berkshire
    Amministratore
    6 Setter Combe
    RG42 2FD Warfield
    Berkshire
    BritishFinancial Controller76155240003
    TRAVERS SMITH LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Amministratore delegato nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006090001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Amministratore delegato nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001

    PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture dated 29 july 2000 as amended and restated on 11 august 2000 by a composite restatement agreement dated 10 august 2000 (the "debenture") issued by the company
    Creato il 11 ago 2000
    Consegnato il 16 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee all money or liabilities due owing or incurred to any secured party by the charging company or any other charging company under the debenture or any other obligor under any finance document in whatsoever manner
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 16 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 lug 2000
    Consegnato il 02 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein and each of the other obligors under the debenture and under any finance document to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lehman Commercial Paper Inc. (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 02 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0