STANDFORD HOMES LIMITED
Panoramica
Nome della società | STANDFORD HOMES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04025159 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di STANDFORD HOMES LIMITED?
- Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova STANDFORD HOMES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di STANDFORD HOMES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CASEGROVE LIMITED | 03 lug 2000 | 03 lug 2000 |
Quali sono gli ultimi bilanci di STANDFORD HOMES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per STANDFORD HOMES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione | 6 pagine | 1.4 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 lug 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore | 4 pagine | 1.1 | ||||||||||
Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2010 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 lug 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | 7 pagine | MG01 | ||||||||||
Nomina di Mr Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Mcleish come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 lug 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 27 set 2009 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di un amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kamma Foulkes come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di STANDFORD HOMES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYLOR, Stephen Jonathan | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 163496070001 | ||||
HARGROVE, Ian Mark, Mr. | Segretario | Moorcourt Farm Weston Road Lewknor OX49 5RU Watlington Oxfordshire | British | Accountant | 152141720001 | |||||
MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Segretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158661770001 | |||||||
MCLEISH, William David | Segretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
MCPHEE, Colin James | Segretario | The Laurels Bartons Road PO9 5NA Havant Hampshire | British | Property Director | 95548300002 | |||||
RUTTER, Christopher | Segretario | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | Director | 103588940001 | |||||
LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
BOLOT, Timothy James | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 107837080002 | ||||
BUCHAN, William James | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 79917240001 | ||||
COLVIN, William | Amministratore | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | Director | 51697890003 | ||||
FARMER, Nicholas John | Amministratore | 62 Freshwater Close Great Sankey WA5 3PU Warrington Cheshire | United Kingdom | British | Director | 124228290001 | ||||
FOULKES, Kamma | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 111188390002 | ||||
FOULKES, Kamma | Amministratore | 17 Lower Castle Street NP7 5EE Abergavenny Monmouthshire | United Kingdom | British | Managing Director | 111188390002 | ||||
GEE, Andrew Anthony Edward | Amministratore | 83a Sutherland Avenue TN16 3HG Biggin Hill Kent | England | British | Director | 93592160001 | ||||
HARGROVE, Ian Mark, Mr. | Amministratore | Moorcourt Farm Weston Road Lewknor OX49 5RU Watlington Oxfordshire | United Kingdom | British | Accountant | 152141720001 | ||||
LOCK, Jason David | Amministratore | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | Director | 144822040001 | ||||
MIDMER, Richard Neil | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 110640170001 | ||||
MURPHY, John | Amministratore | 21 Montgreenan View KA13 7NL Kilwinning Ayrshire | British | Director | 26177180002 | |||||
MURPHY, John | Amministratore | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | Director | 26177180004 | ||||
POYNTON, Ellen | Amministratore | Whiteoaks 10 St Richards Close, Wychbold WR9 7PP Droitwich | United Kingdom | British | Director | 89071020004 | ||||
PRESTON, Mary | Amministratore | 1 Pall Mall Cottage Rivington Lane BL6 7RY Bolton | United Kingdom | British | Director | 124068010001 | ||||
ROBSON, Eirik Peter | Amministratore | Throphill Grange Throphill NE61 3QN Morpeth Northumberland | United Kingdom | British | Property Manager | 96040280001 | ||||
RUTTER, Christopher | Amministratore | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | Director | 103588940001 | |||||
SCOTT, Philip Henry | Amministratore | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | Director | 174231320001 | ||||
SEDNAOUI, Paul | Amministratore | Pinewood Lodge Swinley Road SL5 8BA Ascot | British | Company Director | 72955710004 | |||||
SIZER, Graham Kevin | Amministratore | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | Director | 77274540003 | ||||
SMITH, David Andrew, Mr. | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 147997950001 | ||||
ZARBAFI, Amir | Amministratore | Flat 168 Bickenhall Mansions Bickenhall Street W1H 3DF London | British | Property Developer | 18424770009 | |||||
LONDON LAW SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
STANDFORD HOMES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Supplemental legal mortgage | Creato il 06 mag 2011 Consegnato il 20 mag 2011 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 3 garnet road willesden t/no NGL850130. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 29 feb 2008 Consegnato il 14 mar 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 06 giu 2007 Consegnato il 19 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 07 lug 2006 Consegnato il 20 lug 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 08 apr 2005 Consegnato il 15 apr 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 03 apr 2002 Consegnato il 08 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 03 apr 2002 Consegnato il 08 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 3 garnet road willesden london NW10. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
STANDFORD HOMES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA) |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0