ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED

ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04033332
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROADOAKS VCT LIMITED28 set 200028 set 2000
    HILLGATE (181) LIMITED13 lug 200013 lug 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012

    1 pagineTM02

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    6 pagine1.4

    Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 13 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 lug 2012

    Stato del capitale al 17 lug 2012

    • Capitale: GBP 11,190
    SH01

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    4 pagine1.1

    Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    27 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    legacy

    7 pagineMG01

    Cessazione della carica di William Mcleish come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 13 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Enter agreements 14/05/2010
    RES13

    Bilancio redatto al 27 set 2009

    24 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di un amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    GAIN, Jonathan Mark
    9 Nash Place
    HP10 8ES Penn
    Buckinghamshire
    Segretario
    9 Nash Place
    HP10 8ES Penn
    Buckinghamshire
    British47508930005
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304380001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Segretario
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    British174231320001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Segretario nominato
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018850001
    BETTUM, Ole
    54 Primrose Gardens
    NW3 4TP London
    Amministratore
    54 Primrose Gardens
    NW3 4TP London
    EnglandNorwegian50551730002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    BURGESS, Richard John
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    Amministratore
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British35427700001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    FARMER, Nicholas John
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish124228290001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    FRYER, Martin
    The Badgers
    Cats Lane
    CO10 2SF Sudbury
    Suffolk
    Amministratore
    The Badgers
    Cats Lane
    CO10 2SF Sudbury
    Suffolk
    British72517560003
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Amministratore
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Amministratore
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    MURRAY, Andrew John
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    British110957990001
    ROBINSON, Anthony Leake
    The Rose Garden
    Orchehill Avenue
    SL9 8QE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Rose Garden
    Orchehill Avenue
    SL9 8QE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British48323880002
    ROGERS, Michael Greig
    1 Jenningsbury Court
    London Road
    SG13 7NS Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Jenningsbury Court
    London Road
    SG13 7NS Hertford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish107156650001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Amministratore
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Amministratore
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Amministratore
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    HILLGATE NOMINEES LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Amministratore delegato nominato
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018840001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Amministratore delegato nominato
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018850001

    ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental legal mortgage
    Creato il 06 mag 2011
    Consegnato il 20 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Broad oaks gaul road march t/no CB295973 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 20 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 29 feb 2008
    Consegnato il 14 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 14 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 06 giu 2007
    Consegnato il 19 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 19 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 lug 2006
    Consegnato il 20 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 20 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 apr 2005
    Consegnato il 15 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 set 2004
    Consegnato il 28 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 28 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 apr 2004
    Consegnato il 11 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transazioni
    • 11 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 set 2000
    Consegnato il 19 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan stock deed whereby the company issued to the lender 14% secured stock loan
    Brevi particolari
    Land at gaul road march cambridgeshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Venture Capital Trust PLC
    Transazioni
    • 19 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 giu 2012Data della riunione per approvare il CVA
    20 ago 2012Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praticante
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0