TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED

TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04033456
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PAGE & MOY TRAVEL GROUP LIMITED10 mag 201010 mag 2010
    KALEIDOSCOPE TRAVEL HOLDINGS LIMITED20 nov 200720 nov 2007
    TRAVELSPHERE HOLDINGS LIMITED31 ott 200031 ott 2000
    WILLOUGHBY (289) LIMITED13 lug 200013 lug 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:form LIQ12 - secretary of state's release
    3 pagineLIQ MISC

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    18 pagineLIQ14

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    11 pagineLIQ10

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    41 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    33 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    4 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    38 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    8 pagineAM02

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    48 pagine2.17B

    Risultato della riunione dei creditori

    50 pagine2.23B

    Indirizzo della sede legale modificato da 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB a 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB in data 20 gen 2017

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Compass House Rockingham Road Market Harborough Leicestershire LE16 7QD a 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB in data 16 gen 2017

    1 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 30 dic 2016

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Mr Peter Eric Buckley come segretario in data 27 set 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Nigel John Arthur come segretario in data 27 set 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Nigel John Arthur come amministratore in data 27 set 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 ott 2015

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 mar 2016

    Stato del capitale al 17 mar 2016

    • Capitale: GBP 330,160.1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 ott 2014

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 mar 2015

    Stato del capitale al 02 mar 2015

    • Capitale: GBP 330,160.1
    SH01

    Chi sono gli amministratori di TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUCKLEY, Peter Eric
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Segretario
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    215219850001
    ALLARD, Roger Jeffrey
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomEnglish81122260002
    MCKINNON, Tracey Anne
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritish162927400001
    SMITH, Ian
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomBritish5734800003
    WILSON, Colin James
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Amministratore
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritish162927160001
    ARTHUR, Nigel John
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Segretario
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    193406070001
    CLEMSON, David
    New Sawley Grange Farm
    Gisburn Road, Sawley
    BB7 4LH Clitheroe
    Lancashire
    Segretario
    New Sawley Grange Farm
    Gisburn Road, Sawley
    BB7 4LH Clitheroe
    Lancashire
    British68160250001
    GADSBY, Christopher
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Segretario
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    161968210001
    HARDMAN, John Benjamin
    Hill Rise
    Burbage
    LE10 2UA Hinckley
    42
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Hill Rise
    Burbage
    LE10 2UA Hinckley
    42
    Leicestershire
    United Kingdom
    British131024350001
    PARKINSON, Ian
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    Segretario
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    British100921910001
    SIMMONS, Susan
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    British125431690001
    THOMAS, Hywel David
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Segretario
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    British59274640002
    WITTS, Kevan
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Segretario
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    190941910001
    WILLOUGHBY CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Willoughby House
    20 Low Pavement
    NG1 7EA Nottingham
    Segretario nominato
    Willoughby House
    20 Low Pavement
    NG1 7EA Nottingham
    900009590001
    ARTHUR, Nigel John
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandEnglish175689210001
    BRYANT, Robert David
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish152320790001
    BURNS, David Campbell
    12 Broadway
    WA15 0PG Hale
    Cheshire
    Amministratore
    12 Broadway
    WA15 0PG Hale
    Cheshire
    British73653730001
    BURTON, William John
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish64885440001
    CHAPPELOW, Peter Raymond
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish71153170002
    CLEMSON, David
    New Sawley Grange Farm
    Gisburn Road, Sawley
    BB7 4LH Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    New Sawley Grange Farm
    Gisburn Road, Sawley
    BB7 4LH Clitheroe
    Lancashire
    British68160250001
    COE, Albert Henry
    Finvara Blackhurst Brow
    Wilmslow Road
    SK10 4QT Mottram St Andrew
    Cheshire
    Amministratore
    Finvara Blackhurst Brow
    Wilmslow Road
    SK10 4QT Mottram St Andrew
    Cheshire
    United KingdomBritish3977310002
    DUFTY, Andrew
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish161857980002
    EDWARDS, Michael John
    The Hall
    Ketton
    PE9 3RB Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Hall
    Ketton
    PE9 3RB Stamford
    Lincolnshire
    British76861010002
    FOSTER, Stephen Albert
    The Lymes
    295 Gisburn Road
    BB9 6AW Barrowford
    Lancashire
    Amministratore
    The Lymes
    295 Gisburn Road
    BB9 6AW Barrowford
    Lancashire
    United KingdomBritish94033560001
    GADSBY, Christopher James
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish118396090002
    HARVEY, Gillian
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish140490960002
    HEWETSON, Benjamin Anthony Patrick
    62 Sugden Road
    SW11 5EF London
    Amministratore
    62 Sugden Road
    SW11 5EF London
    British105633050001
    MACKAY, Richard
    The Malt House 42 Newbold Road
    Desford
    LE9 9GS Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    The Malt House 42 Newbold Road
    Desford
    LE9 9GS Leicester
    Leicestershire
    British26236830001
    MORRIS, Neil John
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish158818060001
    PARCELL, Graham James
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish52050240001
    PARKINSON, Ian
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    Amministratore
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    British100921910001
    SHARMAN, Jeremy William
    33 King William Street
    EC4R 9AS London
    Amministratore
    33 King William Street
    EC4R 9AS London
    British57824380001
    SIMMONS, Susan
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish125431690001
    THOMAS, Hywel David
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish59274640002
    WATTS, Mark Bingham Titus
    May Tree Lodge
    Newlands, Naseby
    NN6 6DE Northampton
    Amministratore
    May Tree Lodge
    Newlands, Naseby
    NN6 6DE Northampton
    United KingdomBritish43948350004

    TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 15 mag 2012
    Consegnato il 01 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt or debts owing by the bank represented by any such sum or sums (each such sum and debt being a credit balance).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Key-man policy assignment
    Creato il 08 giu 2009
    Consegnato il 11 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Life assured: mr william john burton sum assured: £500,000.00 insurer: legal & general p/no. 013330299-2 term: 3 years with full title guarantee as a continuing security for the payment or discharge of all secured sums assigned absolutely and agreed to assign absolutely all its right, title and interest in and to the proceeds of the policies see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 11 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Insurance assignment
    Creato il 02 mag 2006
    Consegnato il 16 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Insurer phoenix life and pensions life assured david clemson policy number 025794058/001 sum assured £250,000.00 commencement date 10 october 2000. insurer phoenix life and pensions life assured mark watts policy number 0305794058/004 sum assured £250,000.00 commencement date 10 october 2000. insurer scottish equitable PLC life assured sue simmons policy number L019372752 sum assured £250,000.00 commencement date 3 november 2004. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 16 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture accession deed
    Creato il 02 mag 2006
    Consegnato il 16 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transazioni
    • 16 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over shares
    Creato il 28 gen 2005
    Consegnato il 05 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group to each finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all the charged securities referred to in the schedule to form 395 together with (a) all related rights from time to time accruing to those charged securities; and (b) all rights which the company may have at any time against any clearance or settlement system or any custodial rights in respect of any charged securities.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 05 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Insurance assignment
    Creato il 28 gen 2005
    Consegnato il 05 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each finance party or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Right, title and interest in and to the policy. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Agent)
    Transazioni
    • 05 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Insurance assignment
    Creato il 30 nov 2004
    Consegnato il 09 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the company (the "assignor") to each finance party (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All encumbrances and dispositions created or made by or pursuant to the deed and any mortgage,pledge,lien,charge (fixed or floating),assgnmentsecurity interest or trust,etc.all right,title and nterest n and to the policies thereto and all monies including bonuses accrued and payabl; see form 395 for detals. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland the Security Agent
    Transazioni
    • 09 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 nov 2004
    Consegnato il 09 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from any member of the group to each finance party (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland the Security Agent
    Transazioni
    • 09 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over retail division bank account
    Creato il 30 nov 2004
    Consegnato il 09 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each finance party or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Right, title and interest in and to the security account and the account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transazioni
    • 09 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture between the company and the governor and company of the bank of scotland as agent and trustee for itself and each of the lenders (the "security agent")
    Creato il 10 ott 2000
    Consegnato il 18 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on cash collateral deposit
    Creato il 10 ott 2000
    Consegnato il 18 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabiltieis due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the investor agreement (as defined) or the deed
    Brevi particolari
    The chargor as beneficial owner and with full title guarantee as security for the payment first fixed charge all its right title and interest in the deposit moneys it si the sole legal and beneficial owner of the deposit moneys. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 dic 2016Inizio dell'amministrazione
    22 mag 2018Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew Richards
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Edward Williams
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DataTipo
    22 mag 2018Inizio della liquidazione
    01 nov 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Edward Williams
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Matthew Richards
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0