ONEBILL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàONEBILL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04034148
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ONEBILL LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ONEBILL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lindred House 20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ONEBILL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ONEBILL PLC14 lug 200014 lug 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di ONEBILL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2023

    Quali sono le ultime deposizioni per ONEBILL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2023

    16 pagineAA

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 28 giu 2023

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 mar 2022

    22 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA

    1 pagineAD02

    Memorandum e Statuto

    29 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Indirizzo della sede legale modificato da First Floor, Millbank Tower, 21-24 Millbank London SW1P 4QP a Lindred House 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR in data 15 mar 2022

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Neil Francis Conaghan come amministratore in data 04 mar 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christian Nellemann come amministratore in data 04 mar 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stuart Norman Morten come amministratore in data 04 mar 2022

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David Raymond Mcginn come amministratore in data 04 mar 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Panayiotis Koullas come segretario in data 04 mar 2022

    1 pagineTM02

    Soddisfazione dell'onere 040341480010 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2021

    22 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2020

    23 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di ONEBILL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCGINN, David Raymond
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    Amministratore
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    EnglandBritish286701680001
    MORTEN, Stuart Norman
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    Amministratore
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    EnglandBritish253478290001
    BLOODWORTH, Owen
    Thornhill Farm
    Coolham
    RH13 8QN Horsham
    West Sussex
    Segretario
    Thornhill Farm
    Coolham
    RH13 8QN Horsham
    West Sussex
    British109512260001
    GERMAN, Peter James
    17 Kings Crescent
    Shoreham Beach
    BN43 5LE Shoreham By Sea
    West Sussex
    Segretario
    17 Kings Crescent
    Shoreham Beach
    BN43 5LE Shoreham By Sea
    West Sussex
    British59433780003
    KOULLAS, Panayiotis
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    First Floor, Millbank Tower,
    England
    Segretario
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    First Floor, Millbank Tower,
    England
    British127212940002
    NOMINEE SECRETARIES LTD
    3 Garden Walk
    EC2A 3EQ London
    Segretario nominato
    3 Garden Walk
    EC2A 3EQ London
    900006780001
    BLOODWORTH, Owen
    Thornhill Farm
    Coolham
    RH13 8QN Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Thornhill Farm
    Coolham
    RH13 8QN Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish109512260001
    CONAGHAN, Neil Francis
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    First Floor, Millbank Tower,
    England
    Amministratore
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    First Floor, Millbank Tower,
    England
    United KingdomBritish159524670001
    DICKIN, Anthony John
    7 Ferndown Gardens
    KT11 2BH Cobham
    Surrey
    Amministratore
    7 Ferndown Gardens
    KT11 2BH Cobham
    Surrey
    EnglandBritish127212770001
    GERMAN, Peter James
    17 Kings Crescent
    Shoreham Beach
    BN43 5LE Shoreham By Sea
    West Sussex
    Amministratore
    17 Kings Crescent
    Shoreham Beach
    BN43 5LE Shoreham By Sea
    West Sussex
    British59433780003
    KARIBIAN, Anthony Vahan
    Gledhow Gardens
    SW5 0AY London
    13d
    Amministratore
    Gledhow Gardens
    SW5 0AY London
    13d
    United KingdomBritish136539170001
    MARTIN, Anna
    28 Lesser Foxholes
    BN43 5NT Shoreham By Sea
    West Sussex
    Amministratore
    28 Lesser Foxholes
    BN43 5NT Shoreham By Sea
    West Sussex
    United KingdomBritish68530030001
    NELLEMANN, Christian
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    First Floor, Millbank Tower,
    Amministratore
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    First Floor, Millbank Tower,
    EnglandDanish192758240001
    NELLEMANN, Christian
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    First Floor, Millbank Tower,
    England
    Amministratore
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    First Floor, Millbank Tower,
    England
    EnglandDanish192758240001
    SHEIKH, Saeed Mohammed
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    First Floor, Millbank Tower,
    Amministratore
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    First Floor, Millbank Tower,
    EnglandBritish257470750001
    THORNLEY, Graham Michael
    28 Lesser Foxholes
    BN43 5NT Shoreham By Sea
    West Sussex
    Amministratore
    28 Lesser Foxholes
    BN43 5NT Shoreham By Sea
    West Sussex
    EnglandBritish61766650002
    TIPPER, Gary William
    The Avenue
    Sale
    M33 4PJ Manchester
    33
    Lancashire
    Amministratore
    The Avenue
    Sale
    M33 4PJ Manchester
    33
    Lancashire
    United KingdomBritish136539500001
    NOMINEE DIRECTORS LTD
    3 Garden Walk
    EC2A 3EQ London
    Amministratore delegato nominato
    3 Garden Walk
    EC2A 3EQ London
    900006850001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ONEBILL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Onebill Group Limited
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    First Floor, Millbank Tower
    England
    06 apr 2016
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    First Floor, Millbank Tower
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione05531133
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ONEBILL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 dic 2020
    Consegnato il 21 dic 2020
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Please see instrument for further details.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Management Limited
    Transazioni
    • 21 dic 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 mar 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 ott 2014
    Consegnato il 06 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited in Its Capacity as Security Agent
    Transazioni
    • 06 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 dic 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 02 dic 2013
    Consegnato il 05 dic 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Trade mark number 2260289-mark text: onebill 1234567890B telecom (word and mark). Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 05 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Group debenture
    Creato il 24 set 2010
    Consegnato il 06 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the security agent and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 06 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 24 set 2010
    Consegnato il 02 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee, the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eci Ventures Nominees Limited (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 17 feb 2009
    Consegnato il 03 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All f/h,l/h property,all the undertaking,property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Graham Michael Thornley
    Transazioni
    • 03 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 feb 2009
    Consegnato il 20 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (or any of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 20 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 17 feb 2009
    Consegnato il 20 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the security beneficiaries or any of them by any group company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Zeus Private Equity LLP (The “Security Trustee”)
    Transazioni
    • 20 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 02 lug 2004
    Consegnato il 17 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a premium house, 102-108 brighton road, worthing. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 lug 2001
    Consegnato il 26 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0