HUMYNE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHUMYNE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04036104
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HUMYNE LIMITED?

    • Circoli con licenza (56301) / Attività di alloggio e di ristorazione
    • Altre attività di divertimento e di svago n.c.a. (93290) / Attività artistiche, sportive e di divertimento

    Dove si trova HUMYNE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    229 Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HUMYNE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PAGESCHOOL LIMITED18 lug 200018 lug 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di HUMYNE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per HUMYNE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 31 gen 2020

    7 pagineAAMD

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 gen 2020

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 gen 2019

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 lug 2018 al 31 gen 2019

    1 pagineAA01

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    2 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 lug 2017

    10 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Timothy Balman il 09 mar 2018

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Mr Andrew Timothy Balman come persona con controllo significativo il 09 mar 2018

    2 paginePSC04

    Indirizzo della sede legale modificato da 105-107 Beverley Road Hull East Yorkshire HU3 1TS a 229 Spring Bank Hull HU3 1LR in data 10 ott 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio modificato di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2016

    7 pagineAAMD

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2016

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Timothy Balman il 20 feb 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Timothy Balman il 20 feb 2017

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2015

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 lug 2015

    Stato del capitale al 31 lug 2015

    • Capitale: GBP 20,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Timothy Balman il 19 giu 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2014

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HUMYNE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MAYS, David
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    Segretario
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    British71928480002
    BALMAN, Andrew Timothy
    Brigwood
    NE47 6EX Haydon Bridge
    Appletreewick
    England
    Amministratore
    Brigwood
    NE47 6EX Haydon Bridge
    Appletreewick
    England
    EnglandBritish139738340005
    MAYS, David
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    Amministratore
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    EnglandBritish71928480002
    BALMAN, Andrew
    Rosemount
    Elm Bank Road
    NE41 8HT Wylam
    Northumberland
    Segretario
    Rosemount
    Elm Bank Road
    NE41 8HT Wylam
    Northumberland
    British60609250001
    JL NOMINEES TWO LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Segretario nominato
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007220001
    JL NOMINEES ONE LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Amministratore delegato nominato
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007210001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HUMYNE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Andrew Timothy Balman
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    18 lug 2016
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    HUMYNE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 26 gen 2010
    Consegnato il 29 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The wellington club, wellington lane, kingston upon hull t/n HS171063 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 nov 2009
    Consegnato il 11 dic 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of debenture
    Creato il 22 set 2003
    Consegnato il 27 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    105-107 beverley road kingston upon hull HU3 1TS fixed & floating charges over the undertaking & all property & assets prestn & future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Coors Brewers Limited
    Transazioni
    • 27 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 04 lug 2003
    Consegnato il 09 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a the welly club 105-107 beverley road hull HU3 1TS. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 mag 2003
    Consegnato il 24 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 24 mag 2001
    Consegnato il 31 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 105-107 beverley road hull (now k/a the wellington club) t/n HS171063. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 05 mar 2001
    Consegnato il 13 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0