INTERLINK SUPPORT SERVICES LIMITED

INTERLINK SUPPORT SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINTERLINK SUPPORT SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04039018
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INTERLINK SUPPORT SERVICES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova INTERLINK SUPPORT SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    WACO UK LIMITED
    Catfoss Lane
    YO25 8EJ Brandesburton
    East Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INTERLINK SUPPORT SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BARNSILVER SUPPLIES LIMITED24 lug 200024 lug 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di INTERLINK SUPPORT SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per INTERLINK SUPPORT SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 ago 2015

    Stato del capitale al 05 ago 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 ago 2014

    Stato del capitale al 05 ago 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2013

    8 pagineAA

    Nomina di Mr Craig Glover come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Stephen Goodburn come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 24 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 25 lug 2013

    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen John Michael Goodburn il 24 lug 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Stephen John Michael Goodburn il 24 lug 2013

    2 pagineCH03

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012

    8 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 24 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 giu 2011

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Royden Vice come amministratore

    1 pagineTM01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Chi sono gli amministratori di INTERLINK SUPPORT SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GLOVER, Craig
    YO25 8EJ Brandesburton
    Catfoss Lane
    East Yorkshire
    Segretario
    YO25 8EJ Brandesburton
    Catfoss Lane
    East Yorkshire
    181562120001
    DE SA, Eugenio Pereira Carneiro
    4 Hambling Drive
    HU17 9GD Beverley
    East Yorkshire
    Amministratore
    4 Hambling Drive
    HU17 9GD Beverley
    East Yorkshire
    United KingdomPortugueseDirector69998030002
    GOODBURN, Stephen John Michael
    Building No 2 Harrowdene Office Park
    128 Western Services Road
    Woodmead
    Waco International Prop Ltd
    South Africa
    South Africa
    Amministratore
    Building No 2 Harrowdene Office Park
    128 Western Services Road
    Woodmead
    Waco International Prop Ltd
    South Africa
    South Africa
    South AfricaSouth AfricanGroup Financial Director100140030004
    DARLEY, Antony Robert
    50 Nunburnholme Avenue
    HU14 3AN North Ferriby
    North Humberside
    Segretario
    50 Nunburnholme Avenue
    HU14 3AN North Ferriby
    North Humberside
    BritishAccountant113045720001
    GOODBURN, Stephen John Michael
    Building No 2 Harrowdene Office Park
    128 Western Services Road
    Woodmead
    Waco International Prop Ltd
    South Africa
    South Africa
    Segretario
    Building No 2 Harrowdene Office Park
    128 Western Services Road
    Woodmead
    Waco International Prop Ltd
    South Africa
    South Africa
    South AfricanGroup Financial Director100140030002
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Segretario nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    ADDISON, Alvin Mark
    4 Mill Lane
    Foston
    YO25 8BP Driffield
    East Yorkshire
    Amministratore
    4 Mill Lane
    Foston
    YO25 8BP Driffield
    East Yorkshire
    BritishDirector88250740001
    BLAIR, David Hurst
    12 East Street
    PE28 0HJ Kimbolton
    Cambridgeshire
    Amministratore
    12 East Street
    PE28 0HJ Kimbolton
    Cambridgeshire
    EnglandBritishDirector174742370001
    BROWN, Alexander Mitchell
    Flat 19 Painters Yard
    10-14 Old Church Street
    SW3 5DQ London
    Amministratore
    Flat 19 Painters Yard
    10-14 Old Church Street
    SW3 5DQ London
    United KingdomBritishDirector88323600001
    BURT, Richard George Vincent
    The Old Rectory
    Burton Agnes
    YO25 4NB Driffield
    North Humberside
    Amministratore
    The Old Rectory
    Burton Agnes
    YO25 4NB Driffield
    North Humberside
    United KingdomBritishDirector65537860003
    DARLEY, Antony Robert
    50 Nunburnholme Avenue
    HU14 3AN North Ferriby
    North Humberside
    Amministratore
    50 Nunburnholme Avenue
    HU14 3AN North Ferriby
    North Humberside
    BritishAccountant113045720001
    SHIELDS, Alastair Craig Colquhoun
    Pauline House
    19 Middle Street, Nafferton
    YO25 4JS Driffield
    East Yorkshire
    Amministratore
    Pauline House
    19 Middle Street, Nafferton
    YO25 4JS Driffield
    East Yorkshire
    BritishInformation Systems71944410003
    VICE, Royden Thomas
    24 Suikerbossie
    80 Mount Street Bryanston
    Gauteng
    2021
    South Africa
    Amministratore
    24 Suikerbossie
    80 Mount Street Bryanston
    Gauteng
    2021
    South Africa
    South AfricaSouth AfricanCeo80517690001
    WORLLEDGE, Peter John Franklin
    Letham Farmhouse
    EH41 4NW Haddington
    East Lothian
    Amministratore
    Letham Farmhouse
    EH41 4NW Haddington
    East Lothian
    BritishCoo93839300001
    WORLLEDGE, Peter John Franklin
    Letham Farmhouse
    EH41 4NW Haddington
    East Lothian
    Amministratore
    Letham Farmhouse
    EH41 4NW Haddington
    East Lothian
    BritishDirector93839300001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Amministratore delegato nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Chi sono le persone con controllo significativo di INTERLINK SUPPORT SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Waco International Holdings Limited
    Harrowdine Office Park
    128 Western Services Road
    Woodmead
    Building No. 2
    Gauteng, 2148
    South Africa
    06 apr 2016
    Harrowdine Office Park
    128 Western Services Road
    Woodmead
    Building No. 2
    Gauteng, 2148
    South Africa
    No
    Forma giuridicaCompany
    Paese di registrazioneSouth Africa
    Autorità legaleSouth African Law
    Luogo di registrazioneSouth Africa
    Numero di registrazione2012/002104/06
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    INTERLINK SUPPORT SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 19 dic 2005
    Consegnato il 29 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company, each security provider and each transaction party to the chargee or any other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ubs Nominees Pty Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 29 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 06 set 2004
    Consegnato il 17 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by each obligor to the secured parties (or any of them)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 17 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 ott 2002
    Consegnato il 09 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of deposit
    Creato il 03 ott 2002
    Consegnato il 10 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The initial deposit and all other deposits credited to account designation 10103510 with the bank and any addition to that deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or part from such deposit or account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 ago 2002
    Consegnato il 14 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lewis Resources Limited
    Transazioni
    • 14 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0