ENSIGN HOLDINGS LIMITED

ENSIGN HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàENSIGN HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04039129
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ENSIGN HOLDINGS LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova ENSIGN HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ENSIGN HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MINMAR (524) LIMITED24 lug 200024 lug 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di ENSIGN HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per ENSIGN HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 24 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 lug 2010

    Stato del capitale al 27 lug 2010

    • Capitale: GBP 140.36
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Steven Paul Burns il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David James Winkett il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per John David Neal il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per David Edward Cooney il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sharon Maria Boland il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    7 pagine363a

    legacy

    7 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    11 pagineAA

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    12 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di ENSIGN HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOLAND, Sharon Maria
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    Segretario
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    British60727940002
    BURNS, Steven Paul
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    Amministratore
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    United KingdomBritish18761850004
    COONEY, David Edward
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    Amministratore
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    United KingdomBritish72000080003
    NEAL, John David
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    Amministratore
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    British102055920002
    WINKETT, David James
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    Amministratore
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    British73175560002
    BECKERSON, Ian David
    St Omer Road
    GU1 2DB Guildford
    2d
    Surrey
    Segretario
    St Omer Road
    GU1 2DB Guildford
    2d
    Surrey
    British73004250004
    DAWE, Andrew Steven
    51 Cherry Tree Road
    ME8 8JY Rainham
    Kent
    Segretario
    51 Cherry Tree Road
    ME8 8JY Rainham
    Kent
    British96373270001
    PALLOT, Hugh Glen
    143 Gresham Road
    TW18 2AG Staines
    Middlesex
    Segretario
    143 Gresham Road
    TW18 2AG Staines
    Middlesex
    British14485660002
    WILLIAMS, Adrian Charles Harold
    The Upper Flat
    94 Offord Road
    N1 1PF London
    Segretario
    The Upper Flat
    94 Offord Road
    N1 1PF London
    British103327620002
    CLYDE SECRETARIES LIMITED
    51 Eastcheap
    EC3M 1JP London
    Segretario
    51 Eastcheap
    EC3M 1JP London
    38770650001
    ANDREWS, John Michael Geoffrey
    80 Palace Gardens Terrace
    W8 4RS London
    Amministratore
    80 Palace Gardens Terrace
    W8 4RS London
    United KingdomBritish4263690001
    CARTER, Richard Graham
    Mill House
    Brenchley Road, Brenchley
    TN12 7NS Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Mill House
    Brenchley Road, Brenchley
    TN12 7NS Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish562930002
    DUFFY, Christopher William
    7 The Broadwalk
    HA6 2XF Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    7 The Broadwalk
    HA6 2XF Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish67071750001
    LANG, David Mark
    Oak Lodge
    2 Gypsy Lane Great Amwell
    SG12 9RN Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    Oak Lodge
    2 Gypsy Lane Great Amwell
    SG12 9RN Ware
    Hertfordshire
    British83500640003
    PAGE, David William
    Rhoden
    Buckland Hill
    TN5 6QT Wadhurst
    East Sussex
    Amministratore
    Rhoden
    Buckland Hill
    TN5 6QT Wadhurst
    East Sussex
    British61672430001
    PRITCHARD, Michael Stephen Francis
    Allens Wall
    Black Hill
    RH16 2HE Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    Allens Wall
    Black Hill
    RH16 2HE Haywards Heath
    West Sussex
    British79170090001
    YOUNG, James Douglas
    3 Hadham Grove
    Hadham Road
    CM23 2PW Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Hadham Grove
    Hadham Road
    CM23 2PW Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritish159566240001

    ENSIGN HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 26 set 2003
    Consegnato il 03 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £20,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £20,000 being the deposit.
    Persone aventi diritto
    • Cheshire County Council
    Transazioni
    • 03 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture deed
    Creato il 28 mar 2002
    Consegnato il 10 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 nov 2000
    Consegnato il 07 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined) including any liability in respect of any further advances made under the finance documents on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest from time to time in and to all shares in the capital of minmar (527) limited; an account in the name of the company (with account number 90367995) maintained with the bank the proceeds of the keyman policy and all related rights and each of the specific contracts and all related rights floating charge over the whole of the company's undertaking and assets present and future present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0