D.U.K.E. DEVELOPMENT GROUP (UK) LIMITED

D.U.K.E. DEVELOPMENT GROUP (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàD.U.K.E. DEVELOPMENT GROUP (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04045874
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di D.U.K.E. DEVELOPMENT GROUP (UK) LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova D.U.K.E. DEVELOPMENT GROUP (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di D.U.K.E. DEVELOPMENT GROUP (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VALAD DEVELOPMENT GROUP (UK) LIMITED18 set 200718 set 2007
    SCARBOROUGH DEVELOPMENT GROUP LIMITED14 giu 200714 giu 2007
    SCARBOROUGH DEVELOPMENT GROUP PLC27 set 200227 set 2002
    TEESLAND GROUP PLC21 ago 200021 ago 2000
    NEW TEESLAND PLC28 lug 200028 lug 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di D.U.K.E. DEVELOPMENT GROUP (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per D.U.K.E. DEVELOPMENT GROUP (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    14 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 gen 2021

    14 pagineLIQ03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Stephen Jones il 18 dic 2020

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Cromwell Corporate Secretarial Limited il 07 set 2020

    1 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU a The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG in data 12 feb 2020

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 23 gen 2020

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Andrew Paul Richardson come amministratore in data 26 giu 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robert Stephen Jones come amministratore in data 26 giu 2019

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2018 al 31 dic 2018

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2017

    27 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2016

    26 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Valsec Director Limited il 24 feb 2017

    1 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Valad Secretarial Services Limited il 24 feb 2017

    1 pagineCH04

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di D.U.K.E. DEVELOPMENT GROUP (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    Cromwell Property Group
    United Kingdom
    Segretario
    Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    Cromwell Property Group
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazioneSC219311
    133355520004
    JONES, Robert Stephen
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish255392510003
    MADDY, James Edward
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish137459000002
    CROMWELL DIRECTOR LIMITED
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione5307786
    102622300003
    BROOK, Susan Margaret
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    Segretario
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    British72328070001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Segretario
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    British1267050001
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Segretario
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Segretario
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    BROOK, Susan Margaret
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    Amministratore
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    EnglandBritish72328070001
    BROPHY, John Francis
    St Ronans Terrace
    Innerleithen
    EH44 6RB Tweeddale
    38
    Amministratore
    St Ronans Terrace
    Innerleithen
    EH44 6RB Tweeddale
    38
    United KingdomBritish133189190001
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Amministratore
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritish35543830001
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Amministratore
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritish35543830001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Amministratore
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Amministratore
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    EDEN, Andrew Francis
    88 Seymour Street
    W2 2JJ London
    Amministratore
    88 Seymour Street
    W2 2JJ London
    British64212820002
    GRUSELLE, Martin Harold
    Rowan House,
    25 Barley Road, Great Chishill,
    SG8 8SB Royston,
    Hertfordshire,
    Amministratore
    Rowan House,
    25 Barley Road, Great Chishill,
    SG8 8SB Royston,
    Hertfordshire,
    British5584680001
    HANCOCK, Mark Edward
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritish141515870001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    Avenue Louise 541 Ascot Apartments
    Square Du Bois 1050 Ixelles
    Bruxelles
    Belgium
    Amministratore
    Avenue Louise 541 Ascot Apartments
    Square Du Bois 1050 Ixelles
    Bruxelles
    Belgium
    British109250000006
    MCCARTHY, Martyn James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomAustralian126149680033
    OLIVER, Paul Francis
    6 Burnaby Crescent
    Chiswick
    W4 3LH London
    Amministratore
    6 Burnaby Crescent
    Chiswick
    W4 3LH London
    British14735150001
    OLIVER, Paul Francis
    6 Burnaby Crescent
    Chiswick
    W4 3LH London
    Amministratore
    6 Burnaby Crescent
    Chiswick
    W4 3LH London
    British14735150001
    QUEK, Stanley Swee Han, Dr
    Europa House 20 Esplanade
    Scarborough
    YO11 2AQ North Yorkshire
    Amministratore
    Europa House 20 Esplanade
    Scarborough
    YO11 2AQ North Yorkshire
    SingaporeSingaporean123800250001
    RICHARDSON, Andrew Paul
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish96498260002
    RICHARDSON, Andrew Paul
    7 Ormidale Terrace
    EH12 6DY Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    7 Ormidale Terrace
    EH12 6DY Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritish96498260001
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Amministratore
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    ROBERTSON, Ian
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish106197810002
    ROBERTSON, Rachel Elizabeth
    Betchworth House
    101 Westhall Road
    CR6 9HG Warlingham
    Surrey
    Amministratore
    Betchworth House
    101 Westhall Road
    CR6 9HG Warlingham
    Surrey
    EnglandBritish96527400001
    ROCKETT, Jason
    142 Whirlowdale Road
    Millhouses
    S7 2NL Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    142 Whirlowdale Road
    Millhouses
    S7 2NL Sheffield
    South Yorkshire
    British111427410002
    TANDY, Didier Michel
    Europa House 20 Esplanade
    Scarborough
    YO11 2AQ North Yorkshire
    Amministratore
    Europa House 20 Esplanade
    Scarborough
    YO11 2AQ North Yorkshire
    EnglandBritish69909950001
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Amministratore
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    WELLS, David Morrison
    32 Park Copse
    Horsforth
    LS18 5UN Leeds
    Amministratore
    32 Park Copse
    Horsforth
    LS18 5UN Leeds
    United KingdomBritish89226130001
    WELLS, David Morrison
    32 Park Copse
    Horsforth
    LS18 5UN Leeds
    Amministratore
    32 Park Copse
    Horsforth
    LS18 5UN Leeds
    United KingdomBritish89226130001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    Chi sono le persone con controllo significativo di D.U.K.E. DEVELOPMENT GROUP (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    D.U.K.E. Property Holdings (Uk) Limited
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    North Yorkshire
    England
    06 apr 2016
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    North Yorkshire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione4382219
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    D.U.K.E. DEVELOPMENT GROUP (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 mar 2012
    Consegnato il 30 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 30 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 nov 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over shares
    Creato il 01 dic 2011
    Consegnato il 08 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from valad developments (llantrisant) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares being 1 share of £1 in valad developments (llantrisant) limited held by the chargor; any dividend. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 nov 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 01 lug 2009
    Consegnato il 15 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 ago 2000
    Consegnato il 19 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as new teesland PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    D.U.K.E. DEVELOPMENT GROUP (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 gen 2020Inizio della liquidazione
    09 mar 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Geoffrey Wayne Bouchier
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0