TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED

TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04050400
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CITRUSDALE LIMITED10 ago 200010 ago 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 apr 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 gen 2021

    10 pagineLIQ03

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom a Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU in data 27 gen 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 gen 2020

    LRESSP

    Stato del capitale al 30 dic 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 09/12/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 apr 2018

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Kirk Dyson Davis come amministratore in data 31 gen 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard Smothers come amministratore in data 31 gen 2018

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2017

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 01 mag 2016

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Lindsay Anne Keswick come segretario in data 25 apr 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Claire Susan Stewart come segretario in data 25 apr 2016

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ a Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT in data 07 mar 2016

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 22 ago 2015

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Jonathan Robert Langford come amministratore in data 26 gen 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Segretario
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    207524370001
    SMOTHERS, Richard
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish242658700001
    FREEMAN, Charles Truscott
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    British67008750001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592870001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172446200001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181021590001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Segretario
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    BENNETT, Keith Norman
    Handley Wood Cottage
    Longwalls Lane
    DE56 2DU Belper
    Derbyshire
    Amministratore
    Handley Wood Cottage
    Longwalls Lane
    DE56 2DU Belper
    Derbyshire
    British6629880006
    CLARKE, Robert
    71 Arthur Road
    SW19 7DN London
    Amministratore
    71 Arthur Road
    SW19 7DN London
    British40894440004
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    FREEMAN, Charles Truscott
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish67008750001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Amministratore
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KEIGHTLEY SAWDON, Brian David
    12 Dower Park
    SL4 4BQ Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    12 Dower Park
    SL4 4BQ Windsor
    Berkshire
    British34704210001
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    KING, Thomas Rupert
    Upper Maisonette 29 Campden Grove
    W8 4JQ London
    Amministratore
    Upper Maisonette 29 Campden Grove
    W8 4JQ London
    EnglandBritish55630790002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCCOSH, William
    Walnut House
    Burgage Lane
    NG25 0ER Southwell
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Walnut House
    Burgage Lane
    NG25 0ER Southwell
    Nottinghamshire
    EnglandBritish15819540001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    RIKLIN, Cornel Carl
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    Amministratore
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    EnglandSwiss78412270001
    SILLS, Jeffrey Alan
    11 Heath Park Drive
    BR1 2WQ Bromley
    Kent
    Amministratore
    11 Heath Park Drive
    BR1 2WQ Bromley
    Kent
    EnglandBritish94775770001
    SMITH, Benedict James
    Flat 9
    62 Eccleston Square
    SW1V 1PH London
    Amministratore
    Flat 9
    62 Eccleston Square
    SW1V 1PH London
    United KingdomBritish75231110001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Spirit Acquisition Properties Limited
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St. Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    England
    06 apr 2016
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St. Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompaines House
    Numero di registrazione4459630
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 31 ott 2003
    Consegnato il 12 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owned jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to each finance party under each finance document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession to a security agreement dated 28 february 2003
    Creato il 25 apr 2003
    Consegnato il 14 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the obligor to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed security over freehold and leasehold property. By way of first fixed charge all present and future freehold and leasehold property and any rights under any other agreement or document which gives the company a right to occupy or use property wheresoever situate now or hereafter belonging to it. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P., as Agent and Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 14 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 03 set 2000
    Consegnato il 15 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the beneficiaries under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cibc World Markets PLC (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 gen 2020Inizio della liquidazione
    18 apr 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Praticante
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Praticante
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0