PEGA PRINT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPEGA PRINT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04050542
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PEGA PRINT LIMITED?

    • altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova PEGA PRINT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Tabley Court
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PEGA PRINT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per PEGA PRINT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    13 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 01 ago 2020

    12 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 01 ago 2019

    12 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Units 2 & 3 Treeton Centre Rother Crescent Treeton Rotherham South Yorkshire S60 5QY England a 5 Tabley Court Victoria Street Altrincham Cheshire WA14 1EZ in data 29 ago 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    10 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 02 ago 2018

    LRESEX

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 ago 2017 al 31 gen 2018

    1 pagineAA01

    Notifica di Brightplate Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2017

    1 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2016

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 lug 2016

    Stato del capitale al 04 lug 2016

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2015

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Units 1, 2 & 3 Treeton Centre Rother Crescent, Treeton Rotherham South Yorkshire S60 5QY a Units 2 & 3 Treeton Centre Rother Crescent Treeton Rotherham South Yorkshire S60 5QY in data 08 gen 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 10 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 ago 2015

    Stato del capitale al 12 ago 2015

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 040505420006, creata il 30 apr 2015

    22 pagineMR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2014

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 ago 2014

    Stato del capitale al 11 ago 2014

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2013

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PEGA PRINT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SAVAGE, John
    Whiteley Wood House
    50 Woofindin Avenue
    S11 7FG Sheffield
    21
    United Kingdom
    Amministratore
    Whiteley Wood House
    50 Woofindin Avenue
    S11 7FG Sheffield
    21
    United Kingdom
    United KingdomBritish131354840002
    WOOD, Helen
    34 Northlands
    Harthill
    S26 7XZ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    34 Northlands
    Harthill
    S26 7XZ Sheffield
    South Yorkshire
    British71684910001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    NIEMAS, Stephen
    1 Lynton Avenue
    S60 3HE Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    1 Lynton Avenue
    S60 3HE Rotherham
    South Yorkshire
    British71684950001
    WOOD, Gary Richard
    34 Northlands
    Harthill
    S26 7XZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    34 Northlands
    Harthill
    S26 7XZ Sheffield
    South Yorkshire
    British71684970001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PEGA PRINT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Rother Crescent
    Treeton
    S60 5QY Rotherham
    Unit 2
    England
    England
    06 apr 2017
    Rother Crescent
    Treeton
    S60 5QY Rotherham
    Unit 2
    England
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione6945959
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    PEGA PRINT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 apr 2015
    Consegnato il 01 mag 2015
    In corso
    Breve descrizione
    All freehold and leasehold property owned by the company at the charge creation date together with all buildings, structures, fixtures and fittings (including trade and tenant’s fixtures) now thereon or thereon after the charge creation date.. All future freehold and leasehold property of the company together with all buildings, structures, fixtures and fittings (including trade and tenant’s fixtures) now thereon or thereon after the charge creation date.. All present and future patents, patent applications, trade marks and service marks (whether registered or not), design rights (whether registered or not), copyrights and all other intellectual property rights whatsoever and all rights relating thereto (including, without limitation, by way of license) legally or beneficially owned by the company.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 01 mag 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 14 set 2009
    Consegnato il 15 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 15 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 06 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £123,500 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Hidelberg topaz scanner used 993610681 1999 print. Epson 7800 digital proofer used GLL0015392 2006 print. Kodak plate rite 4000 used 532 2002 print. (For further details of chattles charged please refer to the form 395) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 06 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 05 nov 2007
    Consegnato il 14 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 24 gen 2007
    Consegnato il 30 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 30 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 feb 2004
    Consegnato il 26 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    PEGA PRINT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 feb 2021Data di scioglimento
    02 ago 2018Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Neil Henry
    5 Tabley Court Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    Praticante
    5 Tabley Court Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    Michael Simister
    5 Tabley Court Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    Praticante
    5 Tabley Court Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0