CHENEZ LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CHENEZ LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04051925 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CHENEZ LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CHENEZ LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Woodhouse Road Scunthorpe DN16 1BD Lincolnshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di CHENEZ LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per CHENEZ LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 feb 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 feb 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2017 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 feb 2018 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 040519250011 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 ago 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Mr Shaun Griffiths come persona con controllo significativo il 15 ago 2016 | 2 pagine | PSC04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 040519250007 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 040519250008 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 040519250009 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 040519250011, creata il 31 gen 2017 | 20 pagine | MR01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 040519250010 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 040519250010, creata il 03 nov 2016 | 22 pagine | MR01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 ago 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Christine Elizabeth Chapman-Watkinson come amministratore in data 01 gen 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 ago 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CHENEZ LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFFITHS, Shaun | Segretario | Rudding Lane Folifoot HG3 1DQ Harrogate The Old Rudding School North Yorkshire United Kingdom | British | 74370360004 | ||||||
| GRIFFITHS, Shaun | Amministratore | Rudding Lane Folifoot HG3 1DQ Harrogate The Old Rudding School North Yorkshire United Kingdom | England | British | 74370360006 | |||||
| FAULDS, Siobhan Alexia | Segretario | 3 Margaret Street DN40 1JX Immingham North East Lincolnshire | British | 77590280001 | ||||||
| ASHBURTON REGISTRARS LIMITED | Segretario nominato | 12-14 St Marys Street TF10 7AB Newport Shropshire | 900014760001 | |||||||
| TAYLOR & COMPANY | Segretario | Temple Chambers 4 Abbey Road DN32 0HF Grimsby North East Lincolnshire | 42423080001 | |||||||
| CHAPMAN-WATKINSON, Christine Elizabeth | Amministratore | Woodhouse Road Scunthorpe DN16 1BD Lincolnshire | United Kingdom | British | 153071840001 | |||||
| DAY, Richard Hamilton | Amministratore | 6 Hawthorn View Off Kirklands Road BD17 6DU Baildon West Yorkshire | England | British | 192044870001 | |||||
| JABBARY, Christine | Amministratore | Moor Lane Caistor LN7 6SN Market Rasen Moor Farmhouse Lincolnshire United Kingdom | England | British | 188229310001 | |||||
| STEENVOORDEN, Gary | Amministratore | Wold Road DN19 7BT Barrow On Humber Nokomis North Lincolnshire England | England | British | 99535160002 | |||||
| AR NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 12-14 St Marys Street TF10 7AB Newport Shropshire | 900014750001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CHENEZ LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Shaun Griffiths | 06 apr 2016 | Folifoot HG3 1DQ Harrogate The Old Rudding School Rudding Lane North Yorkshire United Kingdom | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
CHENEZ LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 31 gen 2017 Consegnato il 02 feb 2017 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Land and buildings on the south side of woodhouse road scunthorpe t/no HS305004. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 03 nov 2016 Consegnato il 03 nov 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 12 mar 2014 Consegnato il 19 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione F/H woodhouse road scunthorpe t/no.HS305004. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 12 mar 2014 Consegnato il 14 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 09 gen 2014 Consegnato il 11 gen 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione F/H property at woodhouse road scunthorpe t/no HS305004. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 28 feb 2011 Consegnato il 01 mar 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Floating charge all of its undertaking and all of its property asset and rights whatsoever and wheresoever situate,present and future see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental chattel mortgage | Creato il 28 feb 2011 Consegnato il 01 mar 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The non-vesting assets being:- giben type prismatic 2 spt H115 cnc beam saw (yom 1999) c/w rear loading 4 off air tables & all associated equipment 374 99 380, giben type prismatic 2 spt H115 cnc beam saw (yom 2000) c/w rear loading 4 off air tables & all associated equipment 610 00 380, giben type prismatic 2 sp H100 front loading beam saw (yom 2000) c/w 4 off air tables & all associated equipment 520 00 380 (for details of further assets charged please refer to the form MG01). See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental chattel mortgage | Creato il 17 feb 2011 Consegnato il 23 feb 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The assets. Brema type vektor cnc vertical drilling & laydown line (yom 2001). c/w 8 position tool changer infeed conveyor outfeed conveyer and all associated equipment OBR1/01. Costruzioni meccaniche type stp 96 cabinet press (yom 2001). c/w infeed conveyors outfeed conveyors and all associated equipment 011145. bag dust extraction (for further details of the assets charged please refer to the form MG01) see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 08 dic 2003 Consegnato il 22 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The property being premises on woodhouse road, scunthorpe t/no HS305004 and HS305003. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 28 ott 2003 Consegnato il 08 nov 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 24 ott 2000 Consegnato il 28 ott 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0