2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED

2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04057272
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED?

    • Produzione di prodotti a base di carne e di carne di pollame (10130) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova 2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Trinity Park House Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROOMCO (2316) LIMITED22 ago 200022 ago 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di 2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 lug 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per 2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 dic 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 lug 2022

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Ronald Klaas Otto Kers come amministratore in data 26 mag 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Joanne Caroline Kershaw Simmonds come amministratore in data 22 mag 2023

    2 pagineAP01

    Memorandum e Statuto

    14 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Stato del capitale al 19 apr 2023

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Baljinder Kaur Boparan come amministratore in data 24 gen 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ranjit Singh Boparan come amministratore in data 24 gen 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 dic 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2021

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 01 ago 2020

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Craig Ashley Tomkinson il 29 mar 2021

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 lug 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conti modificati per una società dormiente redatti al 28 lug 2018

    8 pagineAAMD

    Chi sono gli amministratori di 2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SIMMONDS, Joanne Caroline Kershaw
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    EnglandBritish309294840001
    TOMKINSON, Craig Ashley
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United KingdomBritish199432160002
    BOPARAN, Ranjit Singh
    Shivalika
    Roman Lane
    B74 3AF Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    Shivalika
    Roman Lane
    B74 3AF Sutton Coldfield
    West Midlands
    British161730930001
    DUFFIELD, Stephen Leslie
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    Segretario
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    British24487000002
    DUKE, Shirley Ann
    Cedar House, Ridge View
    Harmston
    LN5 9GH Lincoln
    Lincolnshire
    Segretario
    Cedar House, Ridge View
    Harmston
    LN5 9GH Lincoln
    Lincolnshire
    British77975660004
    GLANFIELD, Martin James
    Weston House
    Milcote Road
    CV37 8EH Welford On Avon
    Warwickshire
    Segretario
    Weston House
    Milcote Road
    CV37 8EH Welford On Avon
    Warwickshire
    British206032560001
    MCMELLON, Christopher John
    12 Grovehill Crescent
    TR11 3HR Falmouth
    Cornwall
    Segretario
    12 Grovehill Crescent
    TR11 3HR Falmouth
    Cornwall
    British43249730003
    NOBLE, Barry
    Qynton House
    Winderton
    OX15 5JF Banbury
    Oxfordshire
    Segretario
    Qynton House
    Winderton
    OX15 5JF Banbury
    Oxfordshire
    British64538550001
    NOBLE, Barry
    Qynton House
    Winderton
    OX15 5JF Banbury
    Oxfordshire
    Segretario
    Qynton House
    Winderton
    OX15 5JF Banbury
    Oxfordshire
    British64538550001
    SILK, Jon Stanley
    Dial Lane
    West Bromwich
    B70 0EB Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    Dial Lane
    West Bromwich
    B70 0EB Birmingham
    West Midlands
    British95721520002
    SILK, Jon Stanley
    Hatherton House
    The Old Rectory
    WS15 3NL Admaston
    Staffordshire
    Segretario
    Hatherton House
    The Old Rectory
    WS15 3NL Admaston
    Staffordshire
    British95721520002
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BOPARAN, Baljinder Kaur
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish58257960003
    BOPARAN, Ranjit Singh
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish202931710001
    CHALLLIS, Keith
    The Grove
    Ditchingham
    NR35 2QY Bungay
    Suffolk
    Amministratore
    The Grove
    Ditchingham
    NR35 2QY Bungay
    Suffolk
    British76504880001
    DAVIES, Gareth Wyn
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    EnglandBritish109674760001
    FARROW, Raymond
    Low Grange Farm
    Gallamore Lane
    LN8 3US Middle Rasen
    Lincolnshire
    Amministratore
    Low Grange Farm
    Gallamore Lane
    LN8 3US Middle Rasen
    Lincolnshire
    British77975550001
    FINCH, Graham William
    3 High Street
    Blisworth
    NN7 3BJ Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    3 High Street
    Blisworth
    NN7 3BJ Northampton
    Northamptonshire
    British15950480001
    FLETCHER, Martyn Paul
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United KingdomBritish235080230001
    GLANFIELD, Martin James
    Weston House
    Milcote Road
    CV37 8EH Welford On Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Weston House
    Milcote Road
    CV37 8EH Welford On Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish206032560001
    HENDERSON, Stephen
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish103853510001
    IRWIN, Henry James
    Reading Hall
    Denham Corner, Denham
    IP21 5DR Eye
    Suffolk
    Amministratore
    Reading Hall
    Denham Corner, Denham
    IP21 5DR Eye
    Suffolk
    United KingdomBritish89067030001
    KERS, Ronald Klaas Otto, Mr.
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    EnglandDutch170539300001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish84487230001
    LILBURN, David
    Deborah Farm
    Westmoor Lane
    LN1 2JW Kettlethorpe
    Lincolnshire
    Amministratore
    Deborah Farm
    Westmoor Lane
    LN1 2JW Kettlethorpe
    Lincolnshire
    British73948140001
    NICOL, George
    Robinson Farm Bungalow
    Eakring Road Bilsthorpe
    NG22 8SX Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Robinson Farm Bungalow
    Eakring Road Bilsthorpe
    NG22 8SX Newark
    Nottinghamshire
    British33458170002
    NOBLE, Barry
    Qynton House
    Winderton
    OX15 5JF Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Qynton House
    Winderton
    OX15 5JF Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish64538550001
    PARSONS, Richard James, Sales And Marketing Director
    River House
    Huntsham
    EX16 7NQ Tiverton
    Devon
    Amministratore
    River House
    Huntsham
    EX16 7NQ Tiverton
    Devon
    British15792820002
    PIKE, Richard Neil
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United KingdomBritish236794290001
    ROSSER, Andrew James
    Old Bridge Farm
    Plymtree
    EX15 2LR Cullompton
    Devon
    Amministratore
    Old Bridge Farm
    Plymtree
    EX15 2LR Cullompton
    Devon
    United KingdomBritish45284250001
    SILK, Jon Stanley
    Dial Lane
    West Bromwich
    B70 0EB Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Dial Lane
    West Bromwich
    B70 0EB Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish95721520002
    SILK, Jon Stanley
    Hatherton House
    The Old Rectory
    WS15 3NL Admaston
    Staffordshire
    Amministratore
    Hatherton House
    The Old Rectory
    WS15 3NL Admaston
    Staffordshire
    EnglandBritish95721520002
    WEEDS, Graham Raymond
    Bridge Fen
    29 Low Road
    IP20 0HJ Wortwell Harleston
    Norfolk
    Amministratore
    Bridge Fen
    29 Low Road
    IP20 0HJ Wortwell Harleston
    Norfolk
    British74254490001
    WOODRUFF, Chris David Capps
    Penlea
    Darrow Green
    IP20 0BA Denton Harleston
    Norfolk
    Amministratore
    Penlea
    Darrow Green
    IP20 0BA Denton Harleston
    Norfolk
    British74254240001
    WRIXON, Trevor Anthony
    18 Church Hill
    Pinhoe
    EX4 9EX Exeter
    Devon
    Amministratore
    18 Church Hill
    Pinhoe
    EX4 9EX Exeter
    Devon
    British34231870002

    Chi sono le persone con controllo significativo di 2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Boparan Holdings Limited
    Trinity Business Park
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    England
    06 apr 2016
    Trinity Business Park
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneUk Companies House
    Numero di registrazione03558065
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 31 ott 2005
    Consegnato il 09 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a plot 1 dial lane west bromwich t/n WM846607. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 06 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 03 nov 2000
    Consegnato il 14 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land and buildings at george road flixton bungay suffolk t/n SK93345. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 06 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 03 nov 2000
    Consegnato il 14 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the north east side of mark lane east markham and land lying to the south of low street east markham t/nos.NT319508 and NT327202. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 06 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 03 nov 2000
    Consegnato il 14 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the f/h and l/h property k/a land and buildings on the north side of ram boulevard foxhills industrial estate, land and buildings on the west side of park farm road, land at park farm road, scunthorpe and aeration basins and other plant at the british steel biological effluent treatment plant park farm road scunthorpe t/nos.HS158635, HS174411 and HS180528. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 06 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 03 nov 2000
    Consegnato il 14 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the f/h property k/a blundells road tiverton part t/no.DN299470. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 06 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 nov 2000
    Consegnato il 14 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 06 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 03 nov 2000
    Consegnato il 14 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as units 11A and 11B boundary rd,brackley; t/no nn 110166. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 06 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0