MEDICAL SUPPORT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | MEDICAL SUPPORT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04057279 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MEDICAL SUPPORT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED?
- Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova MEDICAL SUPPORT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | c/o C/O INVACARE LIMITED Unit 4 Pencoed Technology Park CF35 5AQ Bridgend Mid Glamorgan |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MEDICAL SUPPORT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
BROOMCO (2327) LIMITED | 22 ago 2000 | 22 ago 2000 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MEDICAL SUPPORT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 nov 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per MEDICAL SUPPORT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 ago 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Kevin Carl Mccarthy come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Rachel Carr come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 ago 2013 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 ago 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * C/O C/O Invacare Limited Unit 4 Pencoed Technology Park Pencoed Bridgend CF35 5HZ* in data 29 ago 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Rachel Mary Carr come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Cox come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon John Cox come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Pearce come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 ago 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MEDICAL SUPPORT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCCARTHY, Kevin Carl | Segretario | c/o C/O Invacare Limited Pencoed Technology Park CF35 5AQ Bridgend Unit 4 Mid Glamorgan United Kingdom | 183857660001 | |||||||
PROSSER, Mark | Amministratore | 126 Merthyr Mawr Road CF31 3NY Bridgend | United Kingdom | British | Director | 101592180002 | ||||
CARR, Rachel Mary | Segretario | c/o C/O Invacare Limited Pencoed Technology Park CF35 5AQ Bridgend Unit 4 Mid Glamorgan United Kingdom | 171372410001 | |||||||
COX, Simon John | Segretario | c/o C/O Invacare Limited Pencoed Technology Park Pencoed CF35 5HZ Bridgend Unit 4 | 164345010001 | |||||||
LEWIS, Jon Anthony | Segretario | 234a Bedwas Road CF83 3AW Caerphilly Mid Glamorgan | British | Chief Executive | 60163170002 | |||||
LUCAS, Anthony Kenvyn | Segretario | Galileo Cottage Commercial Street CF82 7DY Ystrad Mynach Mid Glamorgan | British | Director | 149236560001 | |||||
MORGAN, Stephen John | Segretario | Stoneleigh Court Severn Grove CF11 9ES Cardiff Flat 3 South Glamorgan U K | British | 48700670004 | ||||||
PEARCE, David Thomas | Segretario | c/o C/O Invacare Limited Pencoed Technology Park Pencoed CF35 5HZ Bridgend Unit 4 | 152720730001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
BARBOUR SMITH, James Kenneth Alexander | Amministratore | The Square House Latchmoor Grove SL9 8LN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Director | 80175630001 | |||||
CROSKERY, Colm | Amministratore | 13 Aldridge Road Streetly B74 3TU Birmingham West Midlands | British | Company Director | 72791850003 | |||||
DAVIES, Christopher Erith | Amministratore | Pencarreg Croesyceiliog SA32 8DS Carmarthen | British | Company Director | 48167130003 | |||||
DAVIES, Robert Steven | Amministratore | 2 Gordon Rowley Way SA6 6PL Morriston West Glamorgan | British | Director | 99389930001 | |||||
INCHLEY, Simon Nicholas | Amministratore | The Farmhouse, Top Yard Farm Burnmill Road, Great Bowden LE16 7JB Market Harborough Leicestershire | England | British | Company Director | 64345880002 | ||||
LEWIS, Jon Anthony | Amministratore | 234a Bedwas Road CF83 3AW Caerphilly Mid Glamorgan | British | Director | 60163170002 | |||||
LUCAS, Anthony Kenvyn | Amministratore | Galileo Cottage Commercial Street CF82 7DY Ystrad Mynach Mid Glamorgan | United Kingdom | British | Director | 149236560001 | ||||
NAYLOR, Peter David | Amministratore | 31 Barlows Road Harborne B15 2PN Birmingham | British | Company Director | 73589160004 | |||||
PROSSER, Mark | Amministratore | 126 Merthyr Mawr Road CF31 3NY Bridgend | United Kingdom | British | Director | 101592180002 | ||||
DLA NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per MEDICAL SUPPORT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
22 ago 2016 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
MEDICAL SUPPORT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge over credit balances | Creato il 02 gen 2001 Consegnato il 02 gen 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Own account assignment of life policy | Creato il 08 dic 2000 Consegnato il 18 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Norwich union life assurance policy number 7131629UL, life assured colm croskery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Own account assignment of life policy | Creato il 08 dic 2000 Consegnato il 18 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Norwich union life assurance policy number 7131626UX, life assured jan lewis. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Memorandum of deposit of stocks shares and other marketable securities | Creato il 08 dic 2000 Consegnato il 18 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 250,000 ordinary shares of £1.00 each in M.S.s (europe) limited (no.1177458). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 08 dic 2000 Consegnato il 18 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0