WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED

WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04057457
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?

    • Raccolta di rifiuti non pericolosi (38110) / Captazione, depurazione e distribuzione di acqua; gestione dei rifiuti; attività di bonifica

    Dove si trova WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Indigo House
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WHITE ROSE ENVIRONMENTAL HOLDINGS LIMITED13 nov 200013 nov 2000
    BROOMCO (2331) LIMITED22 ago 200022 ago 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 23 ago 2021

    • Capitale: GBP 0.211937
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di William J Seward come amministratore in data 15 ott 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    6 pagineAA

    Nomina di Mr William Seward come amministratore in data 08 feb 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert John Guice come amministratore in data 08 feb 2019

    1 pagineTM01

    Modifica dei dettagli di Stericycle International Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di John Paul Johnston come amministratore in data 01 ott 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robert John Guice come amministratore in data 01 ott 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Daniel Ginnetti il 04 apr 2017

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GINNETTI, Daniel V
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United StatesAmerican193541820001
    DYSON, Gillian Marie
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    British119888150001
    LLOYD, David Alan
    Floor, Apex House London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Floor, Apex House London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd
    Kent
    United Kingdom
    British155636220001
    MIDDLETON, Stephen John
    Pannell House
    Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Pannell House
    Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    British120304280001
    SANDERS, Penelope Jane
    2 Allerton Park
    LS7 4ND Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    2 Allerton Park
    LS7 4ND Leeds
    West Yorkshire
    British88778740001
    TAYLOR, Richard
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    British106228180001
    TEN BRINK, Fransiscus Johannes Maria
    853 Valley Road
    Glencoe
    Illinois 60022
    Usa
    Segretario
    853 Valley Road
    Glencoe
    Illinois 60022
    Usa
    American98751560001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    ALUTTO, Charles Anthony
    Apex House
    London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd Floor
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Apex House
    London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd Floor
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomAmerican134402900001
    BLYDE, William David
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    British11292060003
    BRANDEL, Elizabeth
    N Sheridan Rd
    Lake Forest
    1020
    Illinois 60045
    Usa
    Amministratore
    N Sheridan Rd
    Lake Forest
    1020
    Illinois 60045
    Usa
    UsaUsa115854300002
    CLESEN, John Fredrick
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    UsaAmerican156396820001
    COPLAND, David
    Floor, Apex House London Road
    Northfleet
    DA11 9PD Gravesend
    2nd
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor, Apex House London Road
    Northfleet
    DA11 9PD Gravesend
    2nd
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish137429730001
    CROSKERY, Colm Tomas
    Pkf Limited Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pkf Limited Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Irish101048750003
    FATCHETT, Brendan John
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish163463840001
    FOSS, Richard Lawrence
    Country Place
    Lake Forest 60045
    882
    Illinois
    Usa
    Amministratore
    Country Place
    Lake Forest 60045
    882
    Illinois
    Usa
    UsaAmerican138699920001
    GRAVER, Neville Leslie Denis
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Irish121247930001
    GUICE, Robert John
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United KingdomBritish203379250001
    HANCOCK, John Reginald
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish150864080001
    HEWITT, Terence John
    Pannel House 6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pannel House 6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    British68234450003
    HIGGINS, Andrew David
    Floor, Apex House
    London Road Northfleet
    DA11 9PD Gravesend
    2nd
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor, Apex House
    London Road Northfleet
    DA11 9PD Gravesend
    2nd
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish146636500001
    HINTON, Andrew Peter
    Flat 57
    Centaur House Great George Street
    LS1 3LA Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Flat 57
    Centaur House Great George Street
    LS1 3LA Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish114646030001
    HUGHES, David
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    Pannell House
    West Yorkshire
    Uk
    Amministratore
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    Pannell House
    West Yorkshire
    Uk
    United KingdomBritish130254390001
    JOHNSTON, John Paul
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    IrelandIrish162398480001
    KOGLER, Richard Thomas
    6228 S. Richmond
    Willowbrook
    Illinois 60527
    Usa
    Amministratore
    6228 S. Richmond
    Willowbrook
    Illinois 60527
    Usa
    American98461760001
    LLOYD, David Alan
    Floor, Apex House London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor, Apex House London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish155636220001
    MIDDLETON, Stephen John
    Pannell House
    Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pannell House
    Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    British120304280001
    MILLER, Mark Collier
    15226 Rockland Road
    60048 Libertyville
    Illinois 60048
    Usa
    Amministratore
    15226 Rockland Road
    60048 Libertyville
    Illinois 60048
    Usa
    UsaAmerican98272530001
    O'BRIEN, James Patrick
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    American106228260001
    SACRANIE, Shazeen Sattar
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    American98272430003
    SEWARD, William J, Mr.
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United StatesAmerican256019320001
    SIMPSON, Paul
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish113998010002
    TEN BRINK, Fransiscus Johannes Maria
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    UsaAmerican98751560001
    WYATT, Nicholas Andrew
    Pannel House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pannel House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    British73704370002
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    England
    06 apr 2016
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione7675418
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Memorandum of deposit
    Creato il 06 nov 2002
    Consegnato il 13 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The "mortgaged securities" being all stock and share certificates and other marketable securities money or any account in the company's name in the bank's books or goods belonging to the company deposited with the bank or in the bank's hands. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transazioni
    • 13 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of assurance policies
    Creato il 06 nov 2002
    Consegnato il 18 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Wren life - syndicate 389 at lloyd's, policy number: 2000/0000000461 nicholas andrew wyatt, wren life - syndicate 389 at lloyd's, policy number: 2000/0000000488 terence john hewitt, and wren life - syndicate 389 at lloyd's, policy number: 2000/0000000462 andrew peter hinton. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transazioni
    • 18 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 dic 2000
    Consegnato il 22 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transazioni
    • 22 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of deposit
    Creato il 21 dic 2000
    Consegnato il 22 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the credit facility
    Brevi particolari
    The "mortgaged securities" being all stock and share certificates and other marketable securities money or any account in the company's name in the bank's books or goods belonging to the company deposited with the bank or in the bank's hands. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V. UK Branch
    Transazioni
    • 22 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0