WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04057457 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?
- Raccolta di rifiuti non pericolosi (38110) / Captazione, depurazione e distribuzione di acqua; gestione dei rifiuti; attività di bonifica
Dove si trova WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Indigo House Sussex Avenue LS10 2LF Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| WHITE ROSE ENVIRONMENTAL HOLDINGS LIMITED | 13 nov 2000 | 13 nov 2000 |
| BROOMCO (2331) LIMITED | 22 ago 2000 | 22 ago 2000 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 23 ago 2021
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 ago 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di William J Seward come amministratore in data 15 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr William Seward come amministratore in data 08 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert John Guice come amministratore in data 08 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Stericycle International Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di John Paul Johnston come amministratore in data 01 ott 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Robert John Guice come amministratore in data 01 ott 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Daniel Ginnetti il 04 apr 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GINNETTI, Daniel V | Amministratore | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire | United States | American | 193541820001 | |||||
| DYSON, Gillian Marie | Segretario | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | 119888150001 | ||||||
| LLOYD, David Alan | Segretario | Floor, Apex House London Road DA11 9PD Northfleet 2nd Kent United Kingdom | British | 155636220001 | ||||||
| MIDDLETON, Stephen John | Segretario | Pannell House Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | 120304280001 | ||||||
| SANDERS, Penelope Jane | Segretario | 2 Allerton Park LS7 4ND Leeds West Yorkshire | British | 88778740001 | ||||||
| TAYLOR, Richard | Segretario | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | 106228180001 | ||||||
| TEN BRINK, Fransiscus Johannes Maria | Segretario | 853 Valley Road Glencoe Illinois 60022 Usa | American | 98751560001 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
| ALUTTO, Charles Anthony | Amministratore | Apex House London Road DA11 9PD Northfleet 2nd Floor Kent United Kingdom | United Kingdom | American | 134402900001 | |||||
| BLYDE, William David | Amministratore | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | 11292060003 | ||||||
| BRANDEL, Elizabeth | Amministratore | N Sheridan Rd Lake Forest 1020 Illinois 60045 Usa | Usa | Usa | 115854300002 | |||||
| CLESEN, John Fredrick | Amministratore | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire United Kingdom | Usa | American | 156396820001 | |||||
| COPLAND, David | Amministratore | Floor, Apex House London Road Northfleet DA11 9PD Gravesend 2nd Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 137429730001 | |||||
| CROSKERY, Colm Tomas | Amministratore | Pkf Limited Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | Irish | 101048750003 | ||||||
| FATCHETT, Brendan John | Amministratore | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 163463840001 | |||||
| FOSS, Richard Lawrence | Amministratore | Country Place Lake Forest 60045 882 Illinois Usa | Usa | American | 138699920001 | |||||
| GRAVER, Neville Leslie Denis | Amministratore | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | Irish | 121247930001 | ||||||
| GUICE, Robert John | Amministratore | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire | United Kingdom | British | 203379250001 | |||||
| HANCOCK, John Reginald | Amministratore | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 150864080001 | |||||
| HEWITT, Terence John | Amministratore | Pannel House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | 68234450003 | ||||||
| HIGGINS, Andrew David | Amministratore | Floor, Apex House London Road Northfleet DA11 9PD Gravesend 2nd Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 146636500001 | |||||
| HINTON, Andrew Peter | Amministratore | Flat 57 Centaur House Great George Street LS1 3LA Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 114646030001 | |||||
| HUGHES, David | Amministratore | 6 Queen Street LS1 2TW Leeds Pannell House West Yorkshire Uk | United Kingdom | British | 130254390001 | |||||
| JOHNSTON, John Paul | Amministratore | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire United Kingdom | Ireland | Irish | 162398480001 | |||||
| KOGLER, Richard Thomas | Amministratore | 6228 S. Richmond Willowbrook Illinois 60527 Usa | American | 98461760001 | ||||||
| LLOYD, David Alan | Amministratore | Floor, Apex House London Road DA11 9PD Northfleet 2nd Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 155636220001 | |||||
| MIDDLETON, Stephen John | Amministratore | Pannell House Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | 120304280001 | ||||||
| MILLER, Mark Collier | Amministratore | 15226 Rockland Road 60048 Libertyville Illinois 60048 Usa | Usa | American | 98272530001 | |||||
| O'BRIEN, James Patrick | Amministratore | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | American | 106228260001 | ||||||
| SACRANIE, Shazeen Sattar | Amministratore | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | American | 98272430003 | ||||||
| SEWARD, William J, Mr. | Amministratore | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire | United States | American | 256019320001 | |||||
| SIMPSON, Paul | Amministratore | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 113998010002 | |||||
| TEN BRINK, Fransiscus Johannes Maria | Amministratore | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire United Kingdom | Usa | American | 98751560001 | |||||
| WYATT, Nicholas Andrew | Amministratore | Pannel House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | 73704370002 | ||||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stericycle International Ltd | 06 apr 2016 | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Memorandum of deposit | Creato il 06 nov 2002 Consegnato il 13 nov 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The "mortgaged securities" being all stock and share certificates and other marketable securities money or any account in the company's name in the bank's books or goods belonging to the company deposited with the bank or in the bank's hands. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage of assurance policies | Creato il 06 nov 2002 Consegnato il 18 nov 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Wren life - syndicate 389 at lloyd's, policy number: 2000/0000000461 nicholas andrew wyatt, wren life - syndicate 389 at lloyd's, policy number: 2000/0000000488 terence john hewitt, and wren life - syndicate 389 at lloyd's, policy number: 2000/0000000462 andrew peter hinton. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 dic 2000 Consegnato il 22 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Memorandum of deposit | Creato il 21 dic 2000 Consegnato il 22 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the credit facility | |
Brevi particolari The "mortgaged securities" being all stock and share certificates and other marketable securities money or any account in the company's name in the bank's books or goods belonging to the company deposited with the bank or in the bank's hands. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0