SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED

SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04063031
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED?

    • (6523) /
    • (9305) /

    Dove si trova SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PINCO 1504 LIMITED31 ago 200031 ago 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 set 2011

    Stato del capitale al 08 set 2011

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Cessazione della carica di Ian Story come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Martin Keith Tyler come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Jeremy Peter Small come segretario

    4 pagineAP03

    Cessazione della carica di Lisa Mcdonell come segretario

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Graham Story il 06 ott 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Graham Story il 06 ott 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Matthew Gibson il 06 ott 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2008

    8 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2007

    8 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2007

    13 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine225

    Chi sono gli amministratori di SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Segretario
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    British158291780001
    GIBSON, Matthew
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish82427280001
    TYLER, Martin Keith
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Great BritainBritish158372390001
    MCDONELL, Lisa Michelle
    50 Valley Drive
    LS29 8PA Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    50 Valley Drive
    LS29 8PA Ilkley
    West Yorkshire
    British88620750001
    SHAY, Ian Lawton
    9 Warwick Crescent
    HG2 8JA Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    9 Warwick Crescent
    HG2 8JA Harrogate
    North Yorkshire
    British9138100003
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    COOK, Geoffrey Graham
    Roxby Manor
    Pickering Road Thornton Le Dale
    YO18 7LH Pickering
    North Yorkshire
    Amministratore
    Roxby Manor
    Pickering Road Thornton Le Dale
    YO18 7LH Pickering
    North Yorkshire
    British51386970005
    EDDINGTON, David
    22 Whitelee Crescent
    Newton Mearns
    G77 6UH Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    22 Whitelee Crescent
    Newton Mearns
    G77 6UH Glasgow
    Lanarkshire
    British63907560001
    FRASER, Angus Mackay
    Dunskey
    66 Newton Grove Newton Mearns
    G77 5QJ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    Dunskey
    66 Newton Grove Newton Mearns
    G77 5QJ Glasgow
    Lanarkshire
    British94391140001
    GREENWAY, John Robert
    11 Oak Tree Close
    Strensall
    YO3 5TE York
    North Yorkshire
    Amministratore
    11 Oak Tree Close
    Strensall
    YO3 5TE York
    North Yorkshire
    British57032610001
    HARRIS, Edward
    18 Beech Crescent
    G77 5BN Newton Mearns
    Glasgow
    Amministratore
    18 Beech Crescent
    G77 5BN Newton Mearns
    Glasgow
    British81098320001
    MEEHAN, Paul Christopher
    9 Appleby Court
    Scotton Gates
    HG5 9LU Knareborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    9 Appleby Court
    Scotton Gates
    HG5 9LU Knareborough
    North Yorkshire
    United KingdomBritish127255230002
    OWEN, David Edward
    Willow Cottage
    Saltaire Road Eldwick
    BD16 3EY Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Willow Cottage
    Saltaire Road Eldwick
    BD16 3EY Bingley
    West Yorkshire
    EnglandBritish2400660001
    POPPLEWELL, Kenneth
    3 Adel Towers Court
    Adel
    LS16 8ER Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 Adel Towers Court
    Adel
    LS16 8ER Leeds
    West Yorkshire
    British43094790001
    PRENTICE, Douglas
    18 Pinewood Walk
    ML10 6UL Strathaven
    Lanarkshire
    Amministratore
    18 Pinewood Walk
    ML10 6UL Strathaven
    Lanarkshire
    British63907770001
    PRESTON, Colin Taylor
    Avalon 4 Denholm Gardens
    Quarter
    ML3 7XY Hamilton
    Lanarkshire
    Amministratore
    Avalon 4 Denholm Gardens
    Quarter
    ML3 7XY Hamilton
    Lanarkshire
    British467360002
    SHAY, Ian Lawton
    9 Warwick Crescent
    HG2 8JA Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    9 Warwick Crescent
    HG2 8JA Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish9138100003
    STORY, Ian Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish75238840004
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001

    SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 mar 2004
    Consegnato il 24 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 24 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mar 2004
    Consegnato il 19 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Geoffrey Graham Cook
    Transazioni
    • 19 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 gen 2001
    Consegnato il 31 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0