PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED

PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04063075
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Riverbank House
    2 Swan Lane
    EC4R 3TT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    XCHANGEPOINT HOLDINGS LIMITED25 ago 200025 ago 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 25 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 set 2015

    Stato del capitale al 16 set 2015

    • Capitale: GBP 325,583.89
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2013

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 set 2014

    Stato del capitale al 08 set 2014

    • Capitale: GBP 325,583.89
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Christopher Mckee il 25 ago 2014

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Darnell Calder il 25 ago 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Turing Mckee il 25 ago 2014

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 35 Vine Street London EC3N 2AA United Kingdom* in data 30 mag 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2012

    10 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 25 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ago 2013

    Stato del capitale al 28 ago 2013

    • Capitale: GBP 325,583.89
    SH01

    Cessazione della carica di Eric Swank come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2011

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * First Floor Vintage Yard 59-63 Bermondsey Street London SE1 3XF England* in data 14 mar 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    18 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Fourth Floor 2-4 Great Eastern Street London EC2A 3NT* in data 27 set 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 25 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Nomina di Mr Richard Darnell Calder come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Christopher Mckee come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Eric Alan Swank come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Christopher Mckee come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Christopher Verdin come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCKEE, Christopher
    c/o Packetexchange (Metro) Limited
    2 Swan Lane
    EC4R 3TT London
    Riverbank House
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Packetexchange (Metro) Limited
    2 Swan Lane
    EC4R 3TT London
    Riverbank House
    United Kingdom
    161503190001
    CALDER, Richard Darnell
    c/o Packetexchange (Metro) Limited
    2 Swan Lane
    EC4R 3TT London
    Riverbank House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Packetexchange (Metro) Limited
    2 Swan Lane
    EC4R 3TT London
    Riverbank House
    United Kingdom
    United StatesAmericanCeo161500230001
    MCKEE, Christopher Turing
    c/o Packetexchange (Metro) Limited
    2 Swan Lane
    EC4R 3TT London
    Riverbank House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Packetexchange (Metro) Limited
    2 Swan Lane
    EC4R 3TT London
    Riverbank House
    United Kingdom
    United StatesAmericanAttorney161500200001
    COLES, Stephen James
    48 Ardmore Lane
    IG9 5SA Buckhurst Hill
    Essex
    Segretario
    48 Ardmore Lane
    IG9 5SA Buckhurst Hill
    Essex
    BritishChartered Accountant48921780001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Segretario nominato
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    FAULL, Michele Jean
    Renrag
    Flowers Bottom Lane
    HP27 0PZ Speen
    Buckinghamshire
    Segretario
    Renrag
    Flowers Bottom Lane
    HP27 0PZ Speen
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director82737830001
    O'BRIEN, Kieron
    Tilly Manor
    High Street West Harptree
    BS40 6EB Bristol
    Avon
    Segretario
    Tilly Manor
    High Street West Harptree
    BS40 6EB Bristol
    Avon
    British100281120001
    VERDIN, Christopher Peter
    16 Coates Avenue
    SW18 2TH London
    Segretario
    16 Coates Avenue
    SW18 2TH London
    British61524630003
    VERDIN, Christopher Peter
    16 Coates Avenue
    SW18 2TH London
    Segretario
    16 Coates Avenue
    SW18 2TH London
    BritishAccountant61524630003
    LMG SERVICES LIMITED
    32-35 London Fruit Exchange
    Brushfield Street
    E1 6EU London
    Segretario
    32-35 London Fruit Exchange
    Brushfield Street
    E1 6EU London
    51356760002
    R.B.S. NOMINEES LIMITED
    Challoner House
    19 Clerkenwell Close
    EC1R 0RR London
    Segretario
    Challoner House
    19 Clerkenwell Close
    EC1R 0RR London
    157017420001
    ALMEIDA, Richard Phillip
    Swinley
    Coronation Road
    SL5 9LG Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Swinley
    Coronation Road
    SL5 9LG Ascot
    Berkshire
    EnglandEnglishCompany Director36280330003
    BLACKALL, Laurence Charles Neil
    2 Ravenna Road
    Putney
    SW15 6AW London
    Amministratore
    2 Ravenna Road
    Putney
    SW15 6AW London
    United KingdomBritishInvestor80624810001
    BLIGH, Alexander Marc
    75b Nightingale Lane
    SW12 8LY London
    Amministratore
    75b Nightingale Lane
    SW12 8LY London
    BritishCompany Director48718950002
    COLES, Stephen James
    48 Ardmore Lane
    IG9 5SA Buckhurst Hill
    Essex
    Amministratore
    48 Ardmore Lane
    IG9 5SA Buckhurst Hill
    Essex
    EnglandBritishChartered Accountant48921780001
    DWYER, Daniel John
    Goldfinch Close
    Chelsfield
    BR6 6NF Orpington
    14
    Kent
    Amministratore
    Goldfinch Close
    Chelsfield
    BR6 6NF Orpington
    14
    Kent
    United KingdomBritishCompany Registration Agent112335920001
    DWYER, Daniel James
    Fieldstock
    Vicarage Road
    DA5 2AW Bexley
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    Fieldstock
    Vicarage Road
    DA5 2AW Bexley
    Kent
    British900019460001
    FAULL, Michele Jean
    Renrag
    Flowers Bottom Lane
    HP27 0PZ Speen
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Renrag
    Flowers Bottom Lane
    HP27 0PZ Speen
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director82737830001
    ING, Mike
    6 Lady Lane
    CM2 0TF Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    6 Lady Lane
    CM2 0TF Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director116048390001
    LUPBERGER, Dirk, Dr
    Oberfeldallee 8
    Gruenwald
    D 82031
    Germany
    Amministratore
    Oberfeldallee 8
    Gruenwald
    D 82031
    Germany
    GermanDirector93342790001
    MACE, Richard Edward
    Peninsula Road
    01451 Havard
    38
    Usa
    Amministratore
    Peninsula Road
    01451 Havard
    38
    Usa
    United StatesAmericanCompany Director136970830001
    MACPHERSON, Ronald Thomas Stewart, Sir
    27 Archery Close
    W2 2BE London
    Amministratore
    27 Archery Close
    W2 2BE London
    BritishCompany Director49140580001
    MITCHELL, Keith Niven
    10 Priory Gardens
    PE9 2EG Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    10 Priory Gardens
    PE9 2EG Stamford
    Lincolnshire
    BritishCompany Chairman47803380001
    NABAVI, Annette Patricia, Dr
    Claytons Farmhouse
    Newick Lane
    TN20 6RE Mayfield
    East Sussex
    Amministratore
    Claytons Farmhouse
    Newick Lane
    TN20 6RE Mayfield
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Director71771760001
    O'BRIEN, Kieron
    Tilly Manor
    High Street West Harptree
    BS40 6EB Bristol
    Avon
    Amministratore
    Tilly Manor
    High Street West Harptree
    BS40 6EB Bristol
    Avon
    BritishCompany Director100281120001
    SHAW, Rupert Henry Gildroy
    73 Archel Road
    W14 9QL London
    Amministratore
    73 Archel Road
    W14 9QL London
    BritishDirector83965350001
    SWANK, Eric Alan
    Vine Street
    EC3N 2AA London
    35
    United Kingdom
    Amministratore
    Vine Street
    EC3N 2AA London
    35
    United Kingdom
    UsaAmericanCfo161500580001
    TEHRANIAN, Terrence Majid
    12 Queen Anne Street
    W1G 9AU London
    Amministratore
    12 Queen Anne Street
    W1G 9AU London
    AmericanManaging Partner54315530002
    VELODY, Jason
    1 Bousfield Road
    New Cross
    SE14 5TP London
    Amministratore
    1 Bousfield Road
    New Cross
    SE14 5TP London
    United KingdomBritishDirector15341420002
    VERDIN, Christopher Peter
    16 Coates Avenue
    SW18 2TH London
    Amministratore
    16 Coates Avenue
    SW18 2TH London
    EnglandBritishAccountant61524630003
    WILDE, Richard Brett
    20 Summerhouse Lane
    UB9 6HX Harefield
    Middlesex
    Amministratore
    20 Summerhouse Lane
    UB9 6HX Harefield
    Middlesex
    BritishChief Operating Officer80620510001

    PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 15 feb 2011
    Consegnato il 23 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Partners for Growth Iii,L.P.
    Transazioni
    • 23 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 ott 2009
    Consegnato il 07 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Etv Capital S.A.
    Transazioni
    • 07 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 02 nov 2007
    Consegnato il 21 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Etv Capital S A
    Transazioni
    • 21 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 gen 2007
    Consegnato il 24 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Etv Capital S.A.
    Transazioni
    • 24 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 09 ago 2006
    Consegnato il 16 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Etv Capital S.A
    Transazioni
    • 16 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 17 mag 2001
    Consegnato il 30 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the rent deposit deed
    Brevi particolari
    The initial deposit of £10,656.25 made pursuant to the rent deposit deed together with all money from time to time withrawn in accordance with the rent deposit deed from the deposit account opened and maintained pursuant to the rent deposit deed.
    Persone aventi diritto
    • Marney Hobdey Promotions Limited
    Transazioni
    • 30 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0