SERVICED OFFICES UK GP LIMITED

SERVICED OFFICES UK GP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSERVICED OFFICES UK GP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04063878
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CORPORATE CENTRES GP LIMITED15 mar 200115 mar 2001
    STONEMARTIN (GP) LIMITED29 ago 200029 ago 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da St Helen's 1 Undershaft London EC3P 3DQ United Kingdom a 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS in data 27 dic 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 dic 2019

    LRESSP

    Cessazione della carica di Kirsty Ann-Marie Wilman come amministratore in data 02 dic 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Karina Jane Bye come amministratore in data 02 dic 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nicholas Tebbutt come amministratore in data 02 dic 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Julian Miles Cobourne come amministratore in data 02 dic 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jennifer Anne Lisbey come amministratore in data 02 dic 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Rowley Rose come amministratore in data 02 dic 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matthew James Torode come amministratore in data 23 ago 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Jennifer Anne Lisbey come amministratore in data 15 ott 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 set 2018 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Nomina di Mr Matthew Torode come amministratore in data 13 mar 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Leonard Grose come amministratore in data 13 mar 2018

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017

    2 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Tebbutt il 19 mar 2018

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 set 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Cessazione della carica di Catherine Jane Mccall come amministratore in data 28 lug 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr. Nicholas Tebbutt come amministratore in data 28 lug 2017

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Segretario
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione2084205
    1278390004
    BYE, Karina Jane
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritish239237640001
    ROSE, David Rowley
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritish89567200001
    LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    Segretario
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    British62939740001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ASHCROFT, Jonathan Edwin
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritish131434980001
    BURGESS, Quentin James Neilson
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    Amministratore
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    EnglandBritish42896080002
    BURGESS, Quentin James Neilson
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    Amministratore
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    EnglandBritish42896080002
    CLARK, Philip John
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    Amministratore
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    United KingdomBritish101932350001
    COBOURNE, Julian Miles
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    EnglandBritish198725060001
    DAWSON, Robert George Maxwell
    Worrin Road
    Shenfield
    CM15 8DH Brentwood
    64
    Essex
    Amministratore
    Worrin Road
    Shenfield
    CM15 8DH Brentwood
    64
    Essex
    EnglandBritish77316930001
    DRYSDALE, James Ferguson
    Flat 5
    2 Fair Street
    SE1 2XT London
    Amministratore
    Flat 5
    2 Fair Street
    SE1 2XT London
    British61174240003
    ELLIS, Philip Frederick
    Piglet Manner
    Bramerton Road, Burlingham
    NR14 7DE Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Piglet Manner
    Bramerton Road, Burlingham
    NR14 7DE Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish75296640001
    GOTTLIEB, Julius
    8 Southway
    Totteridge
    N20 8EA London
    Amministratore
    8 Southway
    Totteridge
    N20 8EA London
    EnglandBritish32807790002
    GROSE, David Leonard
    c/o Hermes
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Hermes
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    United Kingdom
    United KingdomAustralian120479020001
    JONES, Richard Peter
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    Amministratore
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    EnglandBritish76584200002
    LAXTON, Chris James Wentworth
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritish198871760001
    LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish62939740001
    LINDSEY, Joel Mark Woodliffe
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomNew Zealand140768720001
    LINEHAM, Timothy Mark Vaughan
    Eastgate House
    Park Lane
    TN15 0JD Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Eastgate House
    Park Lane
    TN15 0JD Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish66505360002
    LISBEY, Jennifer Anne
    150 Cheapside
    EC2V 6ET London
    Hermes Investment Management
    United Kingdom
    Amministratore
    150 Cheapside
    EC2V 6ET London
    Hermes Investment Management
    United Kingdom
    United KingdomBritish259968930001
    MANSLEY, Nicholas John Fermor
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    Amministratore
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    EnglandBritish73817060002
    MCCALL, Catherine Jane
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritish204318160001
    MCKEOWN, Audrey
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomIrish124787300002
    SHAH, Nikunj Nalin
    Norval Road
    HA0 3TE Wembley
    16
    Middlesex
    Uk
    Amministratore
    Norval Road
    HA0 3TE Wembley
    16
    Middlesex
    Uk
    United KingdomBritish131325870001
    TEBBUTT, Nicholas, Mr.
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helens
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helens
    United Kingdom
    United KingdomBritish228645590002
    THODAY, Corin Leonard
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritish138095630001
    TORODE, Matthew James
    Cheapside
    EC2U 6ET London
    150
    United Kingdom
    Amministratore
    Cheapside
    EC2U 6ET London
    150
    United Kingdom
    United KingdomBritish196412900002
    TURNER, Alex James
    Priory Way
    SG4 9BH Hitchin
    12
    Hertfordshire
    Amministratore
    Priory Way
    SG4 9BH Hitchin
    12
    Hertfordshire
    United KingdomBritish110252440002
    WILMAN, Kirsty Ann-Marie
    c/o Hermes Fund Managers Limited
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    England
    Amministratore
    c/o Hermes Fund Managers Limited
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    England
    EnglandBritish155163600002
    WISE, David Andrew John
    20 Parkway
    Southgate
    N14 6QU London
    Amministratore
    20 Parkway
    Southgate
    N14 6QU London
    United KingdomBritish74016310001
    WOMACK, Ian Bryan
    116 Union Street
    NR1 2TG Norwich
    Amministratore
    116 Union Street
    NR1 2TG Norwich
    United KingdomBritish33902000002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Norwich Union (Shareholder Gp) Limited
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No. 1
    England
    06 apr 2016
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No. 1
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies
    Numero di registrazione03783750
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SERVICED OFFICES UK GP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 08 dic 2008
    Consegnato il 16 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company as general partner on behalf of the partnership and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a temple circus temple way bristol t/no. BL97044 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 lug 2008
    Consegnato il 22 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a peter house st peter's square manchester t/no GM597635 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 lug 2008
    Consegnato il 22 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 1 victoria square birmingham t/no WM172095 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 lug 2008
    Consegnato il 22 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 45-48 (inclusive) swallow street birmingham T.no WM367351 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Sscotland PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 lug 2008
    Consegnato il 22 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a land on the south side of swallow street birmingham t/no WM368514 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 lug 2008
    Consegnato il 22 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The propert k/a the golden eagle corner of hill street and swallow street birmingham t/no WM389526.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 11 giu 2004
    Consegnato il 19 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property known as forbury square reading. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creato il 25 gen 2002
    Consegnato il 29 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All undertaking property and assets of the partnership whatsoever and wheresoever. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    SERVICED OFFICES UK GP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 dic 2019Inizio della liquidazione
    18 feb 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0