CARP (UK) 2 LIMITED

CARP (UK) 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCARP (UK) 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04066196
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CARP (UK) 2 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CARP (UK) 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    One Edison Rise, New Ollerton
    Newark
    NG22 9DP Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CARP (UK) 2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALNERY NO. 2088 LIMITED06 set 200006 set 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di CARP (UK) 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al23 apr 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per CARP (UK) 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 13 apr 2016

    LRESSP

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 23 mar 2016

    • Capitale: GBP 2.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    The share premium account be cancelled. 22/03/2016
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 16 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 ott 2015

    Stato del capitale al 21 ott 2015

    • Capitale: GBP 9,980,001
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 23 apr 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 ott 2014

    Stato del capitale al 22 ott 2014

    • Capitale: GBP 9,980,001
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Inglett il 01 set 2014

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 24 apr 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 ott 2013

    Stato del capitale al 29 ott 2013

    • Capitale: GBP 9,980,001
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 25 apr 2013

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Martin Peter Dalby il 17 apr 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Martin Peter Dalby il 17 apr 2013

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 26 apr 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di CARP (UK) 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SINGH-DEHAL, Rajbinder
    Knighton Rise
    LE2 2RE Oadby
    6
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Knighton Rise
    LE2 2RE Oadby
    6
    Leicestershire
    United Kingdom
    Other138962680001
    DALBY, Martin Peter
    The Old Granary, Went Farm
    Main Street, Womersley
    DN6 9BQ Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    The Old Granary, Went Farm
    Main Street, Womersley
    DN6 9BQ Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritish83381250004
    INGLETT, Paul
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    Amministratore
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish81617110003
    BRADSHAW, Andrew Philip
    The Chapel House
    Haseley Road
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    Segretario
    The Chapel House
    Haseley Road
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    British114356940001
    BRIGGS, Hugh Alexander
    6 Austral Street
    Kennington
    SE11 4SJ London
    Segretario
    6 Austral Street
    Kennington
    SE11 4SJ London
    British79558350002
    CUMMINS, Diarmuid
    Westfieldbury
    Westland Green
    SG11 2AL Little Hadham
    Hertfordshire
    Segretario
    Westfieldbury
    Westland Green
    SG11 2AL Little Hadham
    Hertfordshire
    British78791890003
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Segretario
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    British50060390001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Segretario
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    PARKER, Timothy Hugh
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    Segretario
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    British138694570001
    STOLL, Peter Huston
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    Segretario
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    United States107030970001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Segretario nominato
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    MOURANT & CO SECRETARIES LIMITED
    PO BOX 87
    22 Grenville Street
    JE4 8PX St Helier
    Jersey
    Channel Islands
    Segretario
    PO BOX 87
    22 Grenville Street
    JE4 8PX St Helier
    Jersey
    Channel Islands
    73684100001
    BARATTA, Joseph Patrick
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Other94259330004
    BONSALL, Margaret Ruth
    Horton Priory
    Monks Horton
    TN25 6DZ Ashford
    Kent
    Amministratore
    Horton Priory
    Monks Horton
    TN25 6DZ Ashford
    Kent
    EnglandBritish69588940001
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Amministratore
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    CHAPMAN, Julia Anne Jennifer
    Vincent Hall Becquet Vincent
    Trinity
    JE3 5FG Jersey
    Amministratore
    Vincent Hall Becquet Vincent
    Trinity
    JE3 5FG Jersey
    United KingdomBritish51408760001
    DALBY, Martin Peter
    12 Easthorpe
    NG25 0HY Southwell
    Nottinghamshire
    Amministratore
    12 Easthorpe
    NG25 0HY Southwell
    Nottinghamshire
    British83381250001
    DALE, Manjit
    84 Highgate
    West Hill
    N6 6LU London
    Amministratore
    84 Highgate
    West Hill
    N6 6LU London
    EnglandBritish69966070002
    DAVIES, Nicola Claire
    Roche Du Lion
    La Grande Route De La Cote
    JE3 6DR Gorey St Martin
    Jersey
    Amministratore
    Roche Du Lion
    La Grande Route De La Cote
    JE3 6DR Gorey St Martin
    Jersey
    British53592710004
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Amministratore
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritish76313640003
    ESSEX CATER, Gareth
    11 Duhamel Place
    St Helier
    JE2 4TP Jersey
    Amministratore
    11 Duhamel Place
    St Helier
    JE2 4TP Jersey
    British91555540001
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Amministratore
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    United KingdomBritish50060390001
    HAWKES, Edward Jonathan Cameron
    143 Taybridge Street
    SW11 5PY London
    Amministratore
    143 Taybridge Street
    SW11 5PY London
    United KingdomBritish93239900002
    JONAS, Marc Nicholas
    Flat 2
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    Amministratore
    Flat 2
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    EnglandBritish55841850004
    MCINTOSH, William Alan
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    Amministratore
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    British46361590002
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Amministratore
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    British98781970001
    PIKE, Chad Rustan
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    Amministratore
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    United KingdomBritish87606860002
    PURSLOW, Christian Mark Cecil
    The Grove
    Warren Park Coombe Hill
    KT2 7HX Kingston Upon Thames
    Amministratore
    The Grove
    Warren Park Coombe Hill
    KT2 7HX Kingston Upon Thames
    United KingdomBritish83244210001
    ROBERTSON, Stephen James
    1 Hereford House
    13 Lauriston Road
    SW19 4JJ London
    Amministratore
    1 Hereford House
    13 Lauriston Road
    SW19 4JJ London
    British78505200001
    SPENCER CHURCHILL, Edward Albert Charles, Lord
    1 Shepherds Place
    Upper Brook Street
    W1K 6ED London
    Amministratore
    1 Shepherds Place
    Upper Brook Street
    W1K 6ED London
    EnglandBritish54889660001
    STOLL, Peter Huston
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    Amministratore
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    United States107030970001
    WILSON, Christopher
    Ilex Wood
    23 Clare Hill
    KT10 9NB Esher
    Surrey
    Amministratore
    Ilex Wood
    23 Clare Hill
    KT10 9NB Esher
    Surrey
    British103272700001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Amministratore delegato nominato
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Amministratore delegato nominato
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002910001

    CARP (UK) 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Borrower deed of charge
    Creato il 28 feb 2012
    Consegnato il 20 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any borrower secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please see form MG01 fixed and floating charge over all property and assets present and future, including shares, insurances, goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (the Borrower Security Trustee)
    Transazioni
    • 20 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Securitisation floating charge debenture
    Creato il 19 giu 2007
    Consegnato il 04 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge all present and future assets property and undertaking (save for any assets situate in jersey). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited
    Transazioni
    • 04 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 19 giu 2007
    Consegnato il 04 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited
    Transazioni
    • 04 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Intercreditor deed
    Creato il 19 giu 2007
    Consegnato il 05 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    If an obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any part of the secured debt or unsecured debt or any secured creditor or un secured creditor receives all or any amount in cash or in kind of the secured debt or unsecured debt as applicable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited
    Transazioni
    • 05 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security over shares deed
    Creato il 19 giu 2007
    Consegnato il 04 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the tax covenant benficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged portfolio meaning in relation to the company its charged shares and related assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited (The Borrower Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 05 nov 2002
    Consegnato il 15 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed equitable charge all securities belonging to the company and by way of floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais (Acting as Security Agent and Trustee for the Beneficiaries and Includes Anysuccessor Appointed by the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 ago 2001
    Consegnato il 05 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations due or to become due from any obligor (as defined) to the chargee as trustee for the secured parties (as defined) (the "trustee") under the facility documents or b team loan documents or the long term facility documentation (all as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 mar 2001
    Consegnato il 19 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness and other liabilities due or to become due from each obligor (as defined) under or in connection with the senior finance documents (as defined) to the chargee as security agent and/or the senior finance parties (as defined) and/or any receiver on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London
    Transazioni
    • 19 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CARP (UK) 2 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 apr 2016Inizio della liquidazione
    29 mar 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0