THRESHER WINES ACQUISITIONS LIMITED

THRESHER WINES ACQUISITIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHRESHER WINES ACQUISITIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04066731
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THRESHER WINES ACQUISITIONS LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova THRESHER WINES ACQUISITIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THRESHER WINES ACQUISITIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CARMELITE ACQUISITIONS LIMITED01 set 200001 set 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di THRESHER WINES ACQUISITIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 giu 2008

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per THRESHER WINES ACQUISITIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per THRESHER WINES ACQUISITIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    6 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 apr 2014

    5 pagine4.68

    Cessazione della carica di Johan Van De Steen come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:court order re. Replacement of liquidator
    24 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 ott 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 apr 2012

    5 pagine4.68

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:miscellaneous - replacement liquidator
    3 pagineLIQ MISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 apr 2011

    7 pagine4.68

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    5 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * 5 New Street Square London EC4A 3TW* in data 22 apr 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di Jonathan Bradley Cleland come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Martin Brett Boden come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Martin Healy come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Andrew Peter Rich come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Johan Peter Van De Steen come amministratore

    3 pagineAP01

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio consolidato redatto al 28 giu 2008

    15 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di THRESHER WINES ACQUISITIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TJG SECRETARIES LIMITED
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    Segretario
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    61729550002
    BODEN, Martin Brett, Mr.
    The Green
    Adderbury
    OX17 3NE Banbury
    South House
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Green
    Adderbury
    OX17 3NE Banbury
    South House
    Oxfordshire
    EnglandBritish146698050001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    Copse Lane
    Chilworth
    SO16 7JY Southampton
    Green Lawns
    Hampshire
    Amministratore
    Copse Lane
    Chilworth
    SO16 7JY Southampton
    Green Lawns
    Hampshire
    United KingdomBritish146698270001
    RICH, Andrew Peter
    Basuto Road
    SW6 4BL London
    41
    Amministratore
    Basuto Road
    SW6 4BL London
    41
    UkBritish138241610001
    AINLEY, Harvey Bertenshaw
    Hawthorn Hill
    Warfield
    RG42 6HE Bracknell
    Tudor Lodge
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hawthorn Hill
    Warfield
    RG42 6HE Bracknell
    Tudor Lodge
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish134262810001
    ALEXANDER, Stephen Harold
    40 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    Amministratore
    40 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    British9796990001
    BYNG-MADDICK, Zillah
    14 Claremont Gardens
    SL7 1BS Marlow
    Bucks
    Amministratore
    14 Claremont Gardens
    SL7 1BS Marlow
    Bucks
    British98032690002
    COOKLIN, Laurence
    Lydford Lodge 17 Totteridge Village
    N20 8PN London
    Amministratore
    Lydford Lodge 17 Totteridge Village
    N20 8PN London
    British2205290001
    DUNCAN, Fraser Scott
    25 Kippington Road
    TN13 2LJ Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    25 Kippington Road
    TN13 2LJ Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish57508670001
    FRESSON, Mark Gerald
    8 The Avenue
    TW9 2AJ Richmond
    Surrey
    Amministratore
    8 The Avenue
    TW9 2AJ Richmond
    Surrey
    British102551560001
    FROST, Graham Edward
    Apartment 5 Marloes
    Park Road Bowdon
    WA14 3JF Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Apartment 5 Marloes
    Park Road Bowdon
    WA14 3JF Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish124882190001
    GOZZETT, Kim
    Hill Farm
    Kelvedon Road Inworth
    CO5 9SX Colchester
    Essex
    Amministratore
    Hill Farm
    Kelvedon Road Inworth
    CO5 9SX Colchester
    Essex
    United KingdomBritish122205910001
    HALLETT, Peter John
    The Square House 5 Shakespeare Road
    NN16 9RB Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Square House 5 Shakespeare Road
    NN16 9RB Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish20621770001
    HANDS, Guy
    90 Kippington Road
    TN13 2LL Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    90 Kippington Road
    TN13 2LL Sevenoaks
    Kent
    British2519120002
    HEALY, Martin William Oliver
    Elgin Avenue
    W9 1HT London
    59 Biddulph Mansions
    Amministratore
    Elgin Avenue
    W9 1HT London
    59 Biddulph Mansions
    EnglandIrish134003120001
    JOHANNSON, Sven
    3 School Cottages
    RH14 0DT Wisborough Green
    West Sussex
    Amministratore
    3 School Cottages
    RH14 0DT Wisborough Green
    West Sussex
    German94880960001
    JOHNSON, Michael Charles
    19 Hillsleigh Road
    W8 7LE London
    Amministratore
    19 Hillsleigh Road
    W8 7LE London
    British71905430001
    KENDALL, Robert Bradley
    32 Russell Road
    W14 8HU London
    Amministratore
    32 Russell Road
    W14 8HU London
    United KingdomBritish81809130002
    KINSKI, Michael John
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritish58643710001
    MASTERS, John Stephen
    Perryfield House
    Stratton Chase Drive
    HP8 4NS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Perryfield House
    Stratton Chase Drive
    HP8 4NS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish189531480001
    PUNJA, Riaz
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    Amministratore
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    United KingdomBritish58870910002
    RANKIN, Yvonne Rose
    The Maples
    Holmes Chapel Road
    WA16 9RD Over Peover
    Cheshire
    Amministratore
    The Maples
    Holmes Chapel Road
    WA16 9RD Over Peover
    Cheshire
    British107621540001
    ROLING, Christopher John
    82 Oak End Way
    SL9 8DB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    82 Oak End Way
    SL9 8DB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British American119379800001
    SIMPSON, Mark
    Library Farm Oxford Road
    Garsington
    OX44 9DA Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Library Farm Oxford Road
    Garsington
    OX44 9DA Oxford
    Oxfordshire
    British125353550001
    SMELT, Richard John
    Orchard House 100 High Street
    Wargrave
    RG10 8DE Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Orchard House 100 High Street
    Wargrave
    RG10 8DE Reading
    Berkshire
    British59819540003
    STEPHENS, Lloyd Anthony
    South Bank
    Warren Farm
    MK43 0TS Ridgmont
    Bedfordshire
    Amministratore
    South Bank
    Warren Farm
    MK43 0TS Ridgmont
    Bedfordshire
    British125923300001
    STEWART, Quentin Richard
    62 Anchor Brew House
    Shad Thames
    SE1 2LY London
    Amministratore
    62 Anchor Brew House
    Shad Thames
    SE1 2LY London
    United KingdomBritish94880800002
    THOMSON, David Malcolm
    60 Brookmans Avenue
    AL9 7QQ Brookmans Park
    Hertfordshire
    Amministratore
    60 Brookmans Avenue
    AL9 7QQ Brookmans Park
    Hertfordshire
    United KingdomBritish103213380001
    VAN DE STEEN, Johan Peter
    54 Jermyn Street
    SW1Y 6LX London
    Vision Capital Llp
    Amministratore
    54 Jermyn Street
    SW1Y 6LX London
    Vision Capital Llp
    UkBelgian96948750004
    WAGGETT, Colin
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    Amministratore
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    British62266600001
    WHITESIDE, Roger Mark
    Crazies Hill Road
    RG10 8LT Wargrave
    Fairmans
    Berkshire
    Amministratore
    Crazies Hill Road
    RG10 8LT Wargrave
    Fairmans
    Berkshire
    EnglandBritish128819260001
    WILLIAMS, David Gay
    24 Dulwich Wood Avenue
    SE19 1HD London
    Amministratore
    24 Dulwich Wood Avenue
    SE19 1HD London
    EnglandBritish75989820001
    WILLIAMSON, Julie Kay
    24 Whittingstall Road
    SW6 4ED London
    Amministratore
    24 Whittingstall Road
    SW6 4ED London
    United KingdomAmerican68142120001
    HUNTSMOOR LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Amministratore delegato nominato
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008150001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Amministratore delegato nominato
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008160001

    THRESHER WINES ACQUISITIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 ago 2004
    Consegnato il 01 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The properties being 18 & 18A bridge street pinner t/n MX193379, 39 st mark's hill surbiton surrey t/n SY295048, 71 high street abbotts langley t/n P37692 for details of further properties charged, please refer to form 395,. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 01 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 17 september 2004 and
    Creato il 10 nov 2003
    Consegnato il 25 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the debtors to any funding party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The properties being 423 dumbarton road glasgow, 360 duke street glasgow, 641 hawthorn street glasgow, for details of further properties charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 25 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement between the company first quench retailing limited and the security agent
    Creato il 16 ott 2000
    Consegnato il 23 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the chargors to any funding party (as defined) under each funding document (as defined) to which the chargors are a party except for the obligation which if it were so included would result in the deed contravening section 151 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    Each of the chargors secures by way of a first equitable mortgage all estates or interests of the chargors in any freehold property or long leasehold property (other than in scotland) and all shares and stocks owned by it or held by any nominee on its behalf and a floating charge (1) all its assets not otherwise effectively mortgaged or charged and (2) all its assets situated in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC (The Security Agent) as Security Agent and Trustee for the Funding Parties
    Transazioni
    • 23 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    THRESHER WINES ACQUISITIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 apr 2010Inizio della liquidazione
    24 ott 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    David John Standish
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0