LINNET HOMES LIMITED

LINNET HOMES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLINNET HOMES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04067002
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LINNET HOMES LIMITED?

    • Attività di agenzie immobiliari (68310) / Attività immobiliari
    • Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari

    Dove si trova LINNET HOMES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Coppice House Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LINNET HOMES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ORIGINSPACE LIMITED07 set 200007 set 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di LINNET HOMES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per LINNET HOMES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 ott 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo

    2 paginePSC08

    Cessazione di Suffolk Housing Society Ltd. come persona con controllo significativo il 31 gen 2020

    1 paginePSC07

    Cessazione della carica di Anna Louise Casbolt come amministratore in data 31 gen 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Giesen come amministratore in data 31 gen 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Glen Samuel Adams come amministratore in data 31 gen 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Helen Margaret Harvey come segretario in data 31 gen 2020

    1 pagineTM02

    Nomina di Katherine Alexandra Brown come amministratore in data 31 gen 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Edward Quintin Marcus come amministratore in data 31 gen 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 ott 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2019

    25 pagineAA

    Cessazione della carica di Anna Casbolt come segretario in data 25 lug 2019

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Helen Margaret Harvey come segretario in data 25 lug 2019

    2 pagineAP03

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    7 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di LINNET HOMES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROWN, Katherine Alexandra
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    Amministratore
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    EnglandBritish266891210001
    MARCUS, Edward Quintin
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    Amministratore
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    EnglandBritish220363260001
    CASBOLT, Anna
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    Segretario
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    251088800001
    CLARKE, Stephen
    Old Mission House
    Saint Botolphs Lane
    IP33 2AX Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Segretario
    Old Mission House
    Saint Botolphs Lane
    IP33 2AX Bury St. Edmunds
    Suffolk
    British72639690001
    HADDEN, Alison
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    Segretario
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    243661340001
    HARVEY, Helen Margaret
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    Segretario
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    261511200001
    MOORE, Karen Gwenville
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    Segretario
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    209155860001
    SIMPSON, Angela
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    Segretario
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    237642680001
    WINSLET, Ian Anthony
    Old Mission House
    Saint Botolphs Lane
    IP33 2AX Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Segretario
    Old Mission House
    Saint Botolphs Lane
    IP33 2AX Bury St. Edmunds
    Suffolk
    158585930001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAMS, Glen Samuel
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    Amministratore
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    EnglandBritish49490230001
    AITKENS, Nigel Baber
    Castle Farm Tuffields Road
    Whepstead
    IP29 4TL Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    Castle Farm Tuffields Road
    Whepstead
    IP29 4TL Bury St Edmunds
    Suffolk
    British29697200001
    CARTER, Richard Alan
    No 1 Beech Paddocks
    Hessett
    IP30 9NR Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    No 1 Beech Paddocks
    Hessett
    IP30 9NR Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritish18610670003
    CASBOLT, Anna Louise
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    Amministratore
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    EnglandBritish199975240001
    CLARKE, Stephen
    Old Mission House
    Saint Botolphs Lane
    IP33 2AX Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    Old Mission House
    Saint Botolphs Lane
    IP33 2AX Bury St. Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritish72639690001
    EVERINGTON, Stephen Derek
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    Amministratore
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    United KingdomBritish89416910003
    FAIRMAN, Bernadine Jaslyn
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    Amministratore
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    EnglandBritish77136880001
    GIESEN, John
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    Amministratore
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    EnglandBritish167858530001
    HADDEN, Alison Jackson
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    Amministratore
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    EnglandBritish235061770001
    HAZELL, George
    Mayfield 125 Westley Road
    IP33 3SA Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    Mayfield 125 Westley Road
    IP33 3SA Bury St Edmunds
    Suffolk
    British26638060001
    HINER, Stephen
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    Amministratore
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    United KingdomBritish170741260001
    MCCLEARY, Marie
    Old Mission House
    Saint Botolphs Lane
    IP33 2AX Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    Old Mission House
    Saint Botolphs Lane
    IP33 2AX Bury St. Edmunds
    Suffolk
    United KingdomBritish211257450001
    PARNELL, Charlotte Angela
    18 Winsford Road
    IP32 7JJ Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    18 Winsford Road
    IP32 7JJ Bury St. Edmunds
    Suffolk
    British74093040001
    PHILP, Susan
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    Amministratore
    Coppice House
    5 Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    EnglandBritish205238330001
    PUGH, Stephen
    Old Mission House
    Saint Botolphs Lane
    IP33 2AX Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    Old Mission House
    Saint Botolphs Lane
    IP33 2AX Bury St. Edmunds
    Suffolk
    United KingdomBritish92529070001
    REES, Roderick Ian
    Red Cottage
    Prussia Lane
    IP33 2AW Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    Red Cottage
    Prussia Lane
    IP33 2AW Bury St Edmunds
    Suffolk
    United KingdomBritish112033880001
    ROBERTS, Sylvia Alice, Jp
    Butlers Colne Road
    Bures
    CO8 5DN Suffolk
    Amministratore
    Butlers Colne Road
    Bures
    CO8 5DN Suffolk
    British100775900001
    TWELVETREE, John Arthur
    Finley Way
    IP33 2BF Bury St Edmunds
    10
    Suffolk
    Amministratore
    Finley Way
    IP33 2BF Bury St Edmunds
    10
    Suffolk
    United KingdomBritish16439390002
    WALLING, Christopher David
    12 Radnor Close
    IP32 7JL Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    12 Radnor Close
    IP32 7JL Bury St. Edmunds
    Suffolk
    British72639820001
    WEAVER, Martin John
    The Little House
    Lady Street
    CO10 9RA Lavenham
    Suffolk
    Amministratore
    The Little House
    Lady Street
    CO10 9RA Lavenham
    Suffolk
    EnglandBritish72870080002
    WEAVER, Martin John
    Hill Green Cottage
    Bury Road
    CO10 9LS Lavenham
    Suffolk
    Amministratore
    Hill Green Cottage
    Bury Road
    CO10 9LS Lavenham
    Suffolk
    British72870080001
    WINSLET, Ian Anthony
    Old Mission House
    Saint Botolphs Lane
    IP33 2AX Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    Old Mission House
    Saint Botolphs Lane
    IP33 2AX Bury St. Edmunds
    Suffolk
    United KingdomBritish135593040001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LINNET HOMES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Suffolk Housing Society Ltd.
    Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    06 apr 2016
    Greenwood Court
    IP32 7GY Bury St. Edmunds
    Coppice House
    England
    Forma giuridicaCo-Operative And Community Benefit Society
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCo-Operative And Community Benefit Societies Act 2014
    Luogo di registrazioneFca
    Numero di registrazione21198r
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per LINNET HOMES LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    19 ott 2020La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    LINNET HOMES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over account
    Creato il 25 feb 2011
    Consegnato il 10 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in the account and the deposit see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Newcastle Building Society (The Society)
    Transazioni
    • 10 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 21 mag 2010
    Consegnato il 28 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    22 lavender house withersfield road haverhill suffolk t/no SK304941, 23 lavender house withersfield road haverhill suffolk t/no SK304953, 24 lavender house withersfield road haverhill suffolk t/no SK304954 (for details of further properties charged please refer to the form MG01); benefit of all rights and claims, guarantees warranties. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Newcastle Building Society
    Transazioni
    • 28 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 01 apr 2008
    Consegnato il 16 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The undertaking of the borrower and all its property and assets both present and future including its goodwill and uncalled capital for the time being.
    Persone aventi diritto
    • Suffolk Housing Society Limited
    Transazioni
    • 16 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 2008
    • 07 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 10 mar 2006
    Consegnato il 15 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The undertaking of the borrower and all its property and assets both present and future including its goodwill and uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Suffolk Housing Society Limited
    Transazioni
    • 15 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment of rents
    Creato il 28 mar 2002
    Consegnato il 12 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The benefit of all rents, licence or tenancy fees payable by any lessee, licencee or tenant of the land k/a f/h property k/a plots 1-15 jubilee court, thetford, norfolk t/no. NK211064.
    Persone aventi diritto
    • Newcastle Building Society
    Transazioni
    • 12 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 mar 2002
    Consegnato il 12 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a plots 1-15 jubilee court, thetford, norfolk t/no. NK211064.
    Persone aventi diritto
    • Newcastle Building Society
    Transazioni
    • 12 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 18 gen 2002
    Consegnato il 25 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property any shares or membership riights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property, all that freehold land and buildings forming part of t/no. SK189393 and comprising plots 1 - 9 inclusive, blooms court, mildenhall, suffolk, including, without limitation, any boundary walls and fences and all plant, machinery, equipment and other items from time to time affixed to such property/properties.
    Persone aventi diritto
    • Newcastle Building Society
    Transazioni
    • 25 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of rents
    Creato il 18 gen 2002
    Consegnato il 25 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All sums from time to time pursuant to any lease underlease sublease tenancy or licence (or other agreement allowing third party possession) of any part of the property inclusive of any sum paid as security for future rent insurance maintenance or service charge and all rights and claims of the company against any lessee, sub-lessee, licencee or other occupier of the whole or any part of the property and all guarantees and sureties for the obligations of any such occupier now or in the future, property being:- all that freehold land and buildings forming part of the title t/no. SK189393 and comprising plots 1 - 9 (inclusive), blooms court, mildenhall, suffolk, including, without limitation, any boundary walls and fences and all plant, machinery, equipment and other items from time to time affixed to such property/properties.
    Persone aventi diritto
    • Newcastle Building Society
    Transazioni
    • 25 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 04 mag 2001
    Consegnato il 23 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The undertaking of the company and all its property and assets both present and future including its goodwill and uncalled capital for the time being.
    Persone aventi diritto
    • Suffolk Housing Society Limited
    Transazioni
    • 23 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of rents
    Creato il 13 dic 2000
    Consegnato il 20 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All sums from time to time pursuant to any lease underlease sublease tenancy or licence (or other agreement allowing third party possession) of any part of the properties k/a 19-33 (inclusive) 37 and 38 thornhill place longstanton cambridgeshire inclusive of any sum paid as security for future rent insurance maintenance or service charge and all rights and claims against any occupier of any of the properties. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Newcastle Building Society
    Transazioni
    • 20 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 13 dic 2000
    Consegnato il 20 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    19-33 (inclusive) 37 and 38 thornhill place lonstanton cambridgeshire CB222677. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Newcastle Building Society
    Transazioni
    • 20 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over account
    Creato il 07 dic 2000
    Consegnato il 20 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a loan agreement dated 7TH september 2000
    Brevi particolari
    All the company's right title anmd interest in a specified account to be opened by the company pursuant to the loan agreement.
    Persone aventi diritto
    • Newcastle Building Society
    Transazioni
    • 20 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 07 dic 2000
    Consegnato il 20 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over the undertaking and all assets of the company inclusive of goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Newcastle Building Society
    Transazioni
    • 20 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0