CAV AEROSPACE LIMITED

CAV AEROSPACE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAV AEROSPACE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04069894
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAV AEROSPACE LIMITED?

    • fabbricazione di aeromobili e veicoli spaziali e relative macchine (30300) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova CAV AEROSPACE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CAV AEROSPACE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AEROSPACE SYSTEMS AND TECHNOLOGIES 2000 LIMITED01 giu 200101 giu 2001
    CELTIC AEROSPACE VENTURES LIMITED07 nov 200007 nov 2000
    FILBUK 632 LIMITED12 set 200012 set 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAV AEROSPACE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per CAV AEROSPACE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    19 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    17 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    16 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    16 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    17 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    17 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B

    10 pagine2.16B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    50 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    47 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Number 1 Industrial Estate Consett County Durham DH8 6SR a 4 Brindley Place Birmingham B1 2HZ in data 30 nov 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Cessazione della carica di Michael John Eggleston come amministratore in data 03 giu 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    30 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 040698940025, creata il 22 mar 2016

    9 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 040698940026, creata il 22 mar 2016

    9 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 040698940017 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 040698940018 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 040698940019 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 040698940020 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 040698940022 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di CAV AEROSPACE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WARWICK-SAUNDERS, Richard Meirion
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    United Kingdom
    Segretario
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    United Kingdom
    196460680001
    ASPLIN, Robert Alexander
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    United Kingdom
    Amministratore
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector149870270004
    MILNER, Andrew Rex
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    United Kingdom
    Amministratore
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector200109020001
    CASSIDY, Peter Antony
    6 Chester Close
    Darras Hall
    NE20 9AG Ponteland
    Newcastle On Tyne
    Segretario
    6 Chester Close
    Darras Hall
    NE20 9AG Ponteland
    Newcastle On Tyne
    British80630710001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Sun Alliance House 35 Mosley Street
    NE1 1XX Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    Sun Alliance House 35 Mosley Street
    NE1 1XX Newcastle Upon Tyne
    60471940003
    FILBUK (SECRETARIES) LIMITED
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario nominato
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    900004990001
    MUCKLE SECRETARY LIMITED
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    Time Central
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Segretario
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    Time Central
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5276019
    101749170003
    ALDRIDGE, Mark Nicholas Kennedy
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number 1
    County Durham
    Amministratore
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number 1
    County Durham
    United KingdomBritishDirector196502740001
    CALLAGHAN, Anthony James
    Time Central
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Amministratore
    Time Central
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritishConsultant109785120001
    CASSIDY, Peter Antony
    6 Chester Close
    Darras Hall
    NE20 9AG Ponteland
    Newcastle On Tyne
    Amministratore
    6 Chester Close
    Darras Hall
    NE20 9AG Ponteland
    Newcastle On Tyne
    United KingdomBritishFinancial Director80630710001
    EGGLESTON, Michael John
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number 1
    County Durham
    Amministratore
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number 1
    County Durham
    United KingdomBritishDirector197706470001
    HUMPHREYS, Bryan Ernest
    Time Central
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Amministratore
    Time Central
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritishTechnical Director7232710002
    JONES, Andrew David Willis
    Time Central
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Amministratore
    Time Central
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant80652540001
    KENNEDY, Harry
    21 Longbank Drive
    KA7 4SD Ayr
    Ayrshire
    Amministratore
    21 Longbank Drive
    KA7 4SD Ayr
    Ayrshire
    BritishOperations Director70801300001
    LARGE, Leslie Arthur
    5 Wensley Drive
    Hazel Grove
    SK7 6EW Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    5 Wensley Drive
    Hazel Grove
    SK7 6EW Stockport
    Cheshire
    BritishDesign Operations Director80631410001
    LYLE, John Thomas
    115 Kenton Road
    NE3 4NN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    115 Kenton Road
    NE3 4NN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishInformation Systems Director66547550001
    MCFARLANE, Owen David
    Time Central
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Amministratore
    Time Central
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director56110830005
    MCKINLAY, Robert Murray
    43 Glenavon Park
    BS9 1RW Bristol
    Amministratore
    43 Glenavon Park
    BS9 1RW Bristol
    BritishDirector8393690001
    MOTTERSHEAD, Peter David Leigh
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number 1
    County Durham
    Amministratore
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number 1
    County Durham
    EnglandBritishDirector102140470001
    MOULTON, Jonathan Paul
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number 1
    County Durham
    Amministratore
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number 1
    County Durham
    GuernseyBritishDirector148687630003
    SCHUBERT, David Karl
    Baglan Villas
    Penybryn Pyle
    CF33 6RB Bridgend
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    Baglan Villas
    Penybryn Pyle
    CF33 6RB Bridgend
    Mid Glamorgan
    WalesBritishManaging Director4611080001
    SPENCER, Christopher Robin
    5 The Orchards
    NG31 9GW Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    5 The Orchards
    NG31 9GW Grantham
    Lincolnshire
    BritishSales & Commercial Director100793720001
    FILBUK NOMINEES LIMITED
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore delegato nominato
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    900004980001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CAV AEROSPACE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number One
    County Durham
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number One
    County Durham
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act, 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione09464809
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    CAV AEROSPACE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 22 mar 2016
    Consegnato il 26 mar 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Unit 24 number one industrial estate consett t/no DU180793.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Cav Aerospace Limited
    Transazioni
    • 26 mar 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 22 mar 2016
    Consegnato il 26 mar 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Unit 24 number one industrial estate consett t/no DU180793.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Cav Aerospace Limited
    Transazioni
    • 26 mar 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 26 gen 2016
    Consegnato il 28 gen 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Cav Aerospace Limited
    Transazioni
    • 28 gen 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 26 gen 2016
    Consegnato il 28 gen 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Cav Aerospace Limited
    Transazioni
    • 28 gen 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 19 mar 2015
    Consegnato il 24 mar 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Unit 11 ashville way whetstone t/no LT331487 and BT101/24 number one industrial estate medomsley road consett t/no DU180793 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited (as Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 19 mar 2015
    Consegnato il 26 mar 2015
    In corso
    Breve descrizione
    1) unit 11, ashville way, whetstone, LE8 6NU. Title number: LT331487. 2) BT101/24 number one industrial estate, medomsley road, consett. Title number: DU180793.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Spv 18 Limited
    Transazioni
    • 26 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 17 mar 2015
    Consegnato il 19 mar 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited (as Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 mar 2015
    Consegnato il 19 mar 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited (as Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 25 feb 2014
    Consegnato il 15 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 15 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 25 feb 2014
    Consegnato il 15 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 15 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 07 ott 2013
    Consegnato il 08 ott 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Close Leasing Limited
    Transazioni
    • 08 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 03 ago 2012
    Consegnato il 08 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form MG01 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Barclays bank PLC re cav aerospace limited. Business premium account. Account number 43048632.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of debenture
    Creato il 20 ott 2010
    Consegnato il 27 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 27 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 lug 2009
    Consegnato il 30 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transazioni
    • 30 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 02 dic 2005
    Consegnato il 10 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 1 no 1 industrial estate consett. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    All assets debenture
    Creato il 27 set 2005
    Consegnato il 29 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge on all f/h and l/h property,all fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings and fixed plant and machinery,all spare parts,replacements,modifications and additions,all goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • London Bridge Finance Limited
    Transazioni
    • 29 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 ago 2005
    Consegnato il 03 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ago 2005
    Consegnato il 03 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 11 ashville way, whetstone, leicester. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ago 2005
    Consegnato il 03 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a number one industrial estate, medomsley road, consett, county durham. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 02 ott 2003
    Consegnato il 15 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The hydroflow central coolant, swarf filtration system and boric acid anodising tank together with all additions alterations accessories replacements, substitutions and renewals (the mortgaged chattels) with the full benefit of any guarantee warranty or other obligation, agreements copyrights and insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 21 mar 2002
    Consegnato il 10 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    BT101/24, number one ind. Estate, medomsley road, consett, t/no DU180793. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 21 mar 2002
    Consegnato il 10 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The plant machinery chattels or other equipment, the benefit of any guarantee, agreements, copyrights, patents, trademarks etc, the benefit of all insurances.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2002
    Consegnato il 05 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 19 dic 2001
    Consegnato il 05 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The interest in the deposit account and all money from time to time withdrawn therefrom, deposit account means: a separate interest earning deposit account(s) maintained by the mortgagee into which the initial deposit of £13,218.75 shall be paid.
    Persone aventi diritto
    • Norscot Investments Limited
    Transazioni
    • 05 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 gen 2001
    Consegnato il 15 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CAV AEROSPACE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 nov 2016Inizio dell'amministrazione
    07 set 2019Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Robert James Harding
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Clare Boardman
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0