FIFTHGRANGE LIMITED
Panoramica
Nome della società | FIFTHGRANGE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04071712 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FIFTHGRANGE LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova FIFTHGRANGE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Witan Gate House 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di FIFTHGRANGE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 27 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per FIFTHGRANGE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Damian Garry Mcgloughlin il 12 ott 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Charles Coleman il 12 ott 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simone Tudor come segretario in data 31 ago 2022 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2022 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Homebase (Uk&I) Holdings Limited come persona con controllo significativo il 15 dic 2021 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Homebase Group Limited come persona con controllo significativo il 15 dic 2021 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Andrew Charles Coleman il 15 dic 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Damian Garry Mcgloughlin il 15 dic 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Stato del capitale al 14 dic 2021
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 27 dic 2020 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 29 dic 2019 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 dic 2018 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 giu 2019 al 30 dic 2018 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2018 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ms Simone Tudor come segretario in data 03 gen 2019 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 28 pagine | MA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di FIFTHGRANGE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A G SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London Milton Gate England |
| 90084920001 | ||||||||||
COLEMAN, Andrew Charles | Amministratore | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | England | British | Director | 252067350001 | ||||||||
MCGLOUGHLIN, Damian Garry | Amministratore | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 242086250008 | ||||||||
HAMILTON, Deborah Pamela | Segretario | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | 190890130001 | |||||||||||
MCKELVEY, Penelope Ann | Segretario | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | 179886780001 | |||||||||||
PARKER, Philip Alexander | Segretario | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | British | Company Secretary | 202472990003 | |||||||||
SHENTON, Paul Henry | Segretario | 25 Gilmais Bookham KT23 4RP Leatherhead Surrey | British | 64486620001 | ||||||||||
TUDOR, Simone | Segretario | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | 255103480001 | |||||||||||
WILLIS, Michael Haydn Allen | Segretario | 32 Old Oak Drive NN12 8DN Silverstone Northamptonshire | British | 2684970005 | ||||||||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||||||
ADAMS, David William | Amministratore | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | England | British | Finance Director | 153463840001 | ||||||||
BENTLEY, Gordon Andrew | Amministratore | 7 Hollybush Lane AL5 4AL Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 43125610002 | ||||||||
BOYS, Rodney John | Amministratore | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | United Kingdom | Australian | Chief Financial Officer | 204065540002 | ||||||||
DAVIS, Donald Fuller | Amministratore | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | England | American | Company Director | 153470640001 | ||||||||
DAVIS, Peter-John Charles | Amministratore | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | United Kingdom | Australian | Chief Operating Officer | 240193510002 | ||||||||
FULLER, Neil Frank | Amministratore | Rye House Icknield Way HP23 4JU Tring Hertfordshire | United Kingdom | British | Managing Director | 71239990003 | ||||||||
GRESHAM, Nicholas John | Amministratore | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | United Kingdom | British | Finance Director | 91773790001 | ||||||||
HAMILTON, Deborah Pamela | Amministratore | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | United Kingdom | British | Company Secretary | 116752570006 | ||||||||
HAYDON, David James | Amministratore | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | United Kingdom | Australian | Retail Director | 329593090001 | ||||||||
HOLMES, Colin John | Amministratore | The Stone House Welford Road NN6 8SJ Thornby Northamptonshire | British | Company Secretary | 30687300002 | |||||||||
LAYTON, Matthew Robert | Amministratore delegato nominato | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||||||
LOVERING, John David | Amministratore | 75 Capital Wharf High Street Wapping E1W 1LY London | British | Company Director | 73573160001 | |||||||||
PARKER, Philip Alexander | Amministratore | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | United Kingdom | British | Company Secretary | 202472990003 | ||||||||
POTTER, Cheryl | Amministratore | 175 Hillcrest KT13 8AS Weybridge Surrey | British | Venture Capitalist | 75177990001 | |||||||||
RICHARDS, Martin Edgar | Amministratore delegato nominato | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||||||
SELLARS, Ian | Amministratore | 1 Ranelagh Avenue SW6 3PJ London | United Kingdom | British | Company Director | 107731430001 | ||||||||
SHENTON, Paul Henry | Amministratore | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | England | British | Accountant | 64486620001 | ||||||||
SHERWOOD, Charles Nigel Cross | Amministratore | Cavewood Rectory Lane SG3 6RD Datchworth Hertfordshire | United Kingdom | British | Venture Capitalist | 142567110001 | ||||||||
TEMPLEMAN, Robert William | Amministratore | Greenlands Bellwood Court ME3 8RT St. Mary Hoo Kent | British | Director | 75683610001 | |||||||||
WOODHOUSE, Christopher Kevin | Amministratore | 25 Chester Row SW1W 9JF London | British | Director | 48827150004 |
Chi sono le persone con controllo significativo di FIFTHGRANGE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homebase (Uk&I) Holdings Limited | 15 dic 2021 | 3rd Floor 11-12 St James's Square SW1Y 4LB London Suite 1 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Homebase Group Limited | 01 ago 2016 | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
FIFTHGRANGE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 09 nov 2018 Consegnato il 15 nov 2018 | In corso | ||
Breve descrizione See clause 3.1 of the debenture, which creates a fixed charge over any right, title or interest which the company has now or may subsequently acquire to or in any land (as defined in the debenture). See clause 3.9 of the debenture, which creates a fixed charge over all intellectual property rights (as defined in the debenture) (including all fees, royalties and other rights of every kind relating to or deriving from such rights) such as:. Country mark status app no. App date reg no.. United kingdom. Apotments registered 2544622 14-apr-2010 2544622. united kingdom. Compot registered 2312248 03-oct-2002 2312248. hong kong duracoat registered 300974160 16-oct-2007 300974160. please also see schedule 6 (specified intellectual property) within the debenture for further details (this schedule includes further charged intellectual property rights). L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 01 nov 2018 Consegnato il 06 nov 2018 | In corso | ||
Breve descrizione Not applicable. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 02 mar 2001 Consegnato il 21 mar 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All indebtedness and other liabilities due or to become due from the company to all or any of the finance parties (as defined) and/or any receiver (as defined) under all or any of the finance documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0