UK LAND & PROPERTY NORTH WEST LIMITED

UK LAND & PROPERTY NORTH WEST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUK LAND & PROPERTY NORTH WEST LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04079800
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di UK LAND & PROPERTY NORTH WEST LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova UK LAND & PROPERTY NORTH WEST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di UK LAND & PROPERTY NORTH WEST LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    UK LAND & PROPERTY LIMITED28 set 200028 set 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di UK LAND & PROPERTY NORTH WEST LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per UK LAND & PROPERTY NORTH WEST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    29 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 mag 2023

    19 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 20 Old Bailey London EC4M 7AN a 82 st John Street London EC1M 4JN in data 09 feb 2023

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    14 pagineLIQ10

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    10 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 mag 2022

    20 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 mag 2021

    22 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Moorfields Corporate Recovery Limited 88 Wood Street London EC2V 7QF a 20 Old Bailey London EC4M 7AN in data 05 feb 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 mag 2020

    21 pagineLIQ03

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    19 pagineLIQ10

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 mag 2019

    19 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 mag 2018

    19 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 mag 2017

    19 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 mag 2016

    18 pagine4.68

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 mag 2015

    22 pagine2.24B

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 gen 2015

    19 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    29 pagine2.17B

    Chi sono gli amministratori di UK LAND & PROPERTY NORTH WEST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUCHANAN, Andrea
    Laurel Grange 33 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DN Warrington
    Cheshire
    Segretario
    Laurel Grange 33 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DN Warrington
    Cheshire
    British115545000002
    PARKER, Simon Gary, Mr.
    Churton Lodge
    Chester Road Churton
    CH3 6LA Chester
    Cheshire
    Amministratore
    Churton Lodge
    Chester Road Churton
    CH3 6LA Chester
    Cheshire
    EnglandBritish76749130002
    ALLEN, Nicola Jane
    13 Kestrel Close
    CH49 4PY Upton
    Wirral
    Segretario
    13 Kestrel Close
    CH49 4PY Upton
    Wirral
    British78414930001
    AMBROSE, Lynne
    46 Riding Hill Road
    Knowsley Village
    L34 0EG Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    46 Riding Hill Road
    Knowsley Village
    L34 0EG Liverpool
    Merseyside
    British96746390001
    GOODMAN, Stephen Lionel
    Point Levis
    Brow Lane
    CW9 6JY Antrobus
    Cheshire
    Uk
    Segretario
    Point Levis
    Brow Lane
    CW9 6JY Antrobus
    Cheshire
    Uk
    British68926740001
    LYNCH, James
    25 River Valley View
    IRISH Swords
    Co Dublin
    Ireland
    Segretario
    25 River Valley View
    IRISH Swords
    Co Dublin
    Ireland
    British62051770001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    Segretario nominato
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    900018560001
    SHAOUL, Joseph Michael
    20 Hazelmere Avenue
    Hale Barns
    WA15 0AU Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    20 Hazelmere Avenue
    Hale Barns
    WA15 0AU Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish20145240001
    SHAW, David
    9 Gorsty Hill Close
    Balterley Heath
    CW2 5QS Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    9 Gorsty Hill Close
    Balterley Heath
    CW2 5QS Crewe
    Cheshire
    United KingdomBritish36482830002
    SHERRY, Ian Desmond
    315 South Ferry Quay
    L3 4EE Liverpool
    Amministratore
    315 South Ferry Quay
    L3 4EE Liverpool
    EnglandIrish160379410002
    WOODCOCK, John Hamilton
    Davenport Barn Davenport Park Lane
    Holmes Chapel Road
    CW12 4ST Holmes Chapel
    Cheshire
    Amministratore
    Davenport Barn Davenport Park Lane
    Holmes Chapel Road
    CW12 4ST Holmes Chapel
    Cheshire
    EnglandBritish20897510002
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    Amministratore delegato nominato
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    900018550001

    UK LAND & PROPERTY NORTH WEST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 27 ott 2006
    Consegnato il 02 nov 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 7 union street liverpool t/no MS455758 with fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Asset Finance PLC T/a Anglo Irish Development Finance
    Transazioni
    • 02 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 27 ott 2006
    Consegnato il 02 nov 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a 7 union st, liverpool t/no MS455758 and the benefit of any covenant, agreement or undertaking for roadmaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Asset Finance PLC T/a Anglo Irish Development Finance
    Transazioni
    • 02 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee
    Creato il 14 lug 2006
    Consegnato il 20 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from uklp exchange flags limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    To discharge on demand the borrowers obligations up to a maximium of £3,800,000.00 along with interest from the date of demand. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transazioni
    • 20 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge
    Creato il 22 dic 2003
    Consegnato il 07 gen 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property k/a the customs 7 union tsreet liverpool L3 9QX t/n MS455758 by way of specific charge all the income and rights relating to the property. By way of floating charge all movable plant, machinery, implements, building material of all kinds utensils, furniture and equipment. The undertaking and all other property assets and rights of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 07 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)

    UK LAND & PROPERTY NORTH WEST LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 lug 2014Inizio dell'amministrazione
    22 mag 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon Robert Thomas
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Nicholas H O'Reilly
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    2
    DataTipo
    22 mag 2015Inizio della liquidazione
    19 apr 2024Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Tom Straw
    15th Floor 88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    15th Floor 88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Michael Stephen Elliot Solomons
    20 Old Bailey
    EC4M 7AN London
    Praticante
    20 Old Bailey
    EC4M 7AN London
    Milan Vuceljic
    20 Old Bailey
    EC4M 7AN London
    Praticante
    20 Old Bailey
    EC4M 7AN London
    Nicholas H O'Reilly
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Simon Robert Thomas
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Nicholas H O'Reilly
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Liquidatore proposto
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Simon Robert Thomas
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Liquidatore proposto
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0