CENTURION HOLIDAY GROUP LIMITED

CENTURION HOLIDAY GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCENTURION HOLIDAY GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04081927
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CENTURION HOLIDAY GROUP LIMITED?

    • (6330) /

    Dove si trova CENTURION HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sherlock House
    Baker Street
    W1U 6RD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CENTURION HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INDIGO HOLIDAYS LIMITED27 dic 200127 dic 2001
    CLEAROFF LIMITED27 set 200027 set 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di CENTURION HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per CENTURION HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 feb 2010

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 feb 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 ago 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 feb 2009

    6 pagine4.68

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    1 pagine287

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 20 feb 2008

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio consolidato redatto al 31 ott 2006

    20 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    Bilancio consolidato redatto al 31 ott 2005

    24 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed indigo holidays LIMITED\certificate issued on 24/02/06
    2 pagineCERTNM

    legacy

    1 pagine122

    legacy

    3 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di CENTURION HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    J P SECRETARIAL SERVICES LTD
    East House
    109 South Worple Way
    SW14 8TN London
    Segretario
    East House
    109 South Worple Way
    SW14 8TN London
    101162510001
    BEDLOW, Jacqueline Louise
    Abercorn
    Beech Avenue
    KT24 5PJ Effingham
    Surrey
    Amministratore
    Abercorn
    Beech Avenue
    KT24 5PJ Effingham
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director88895480007
    CLINTON, Robert Paulin
    Hill Farm
    Edmunds Hill, Stradishall
    CB8 8YR Newmarket
    Suffolk
    Amministratore
    Hill Farm
    Edmunds Hill, Stradishall
    CB8 8YR Newmarket
    Suffolk
    EnglandBritishRetired Stockbroker70861710001
    DYSON, Simon Maxim
    130 Barrowgate Road
    Chiswick
    W4 4QP London
    Amministratore
    130 Barrowgate Road
    Chiswick
    W4 4QP London
    United KingdomBritishCompany Director109743660001
    PERRY, Haim
    Holme Place
    Kingswood Rise
    TW20 0NG Egham
    Surrey
    Amministratore
    Holme Place
    Kingswood Rise
    TW20 0NG Egham
    Surrey
    IsraeliDirector35099650002
    D'ARCY, John Lindsay
    2 Rose Cottage
    The Close
    CR4 4LS Mitcham
    Surrey
    Segretario
    2 Rose Cottage
    The Close
    CR4 4LS Mitcham
    Surrey
    BritishDirector53392870001
    PSARIAS, John
    2 Ardoch Road
    SE6 1SJ London
    Segretario
    2 Ardoch Road
    SE6 1SJ London
    British6153540001
    CLP COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    Fifth Floor
    99 Charterhouse Street
    EC1M 6NQ London
    Segretario
    Fifth Floor
    99 Charterhouse Street
    EC1M 6NQ London
    75589480001
    SECRETARIAL SOLUTIONS LIMITED
    99 Charterhouse Street
    EC1M 6NQ London
    Segretario
    99 Charterhouse Street
    EC1M 6NQ London
    81435090001
    ALLARD, Roger Jeffrey
    4a Elystan Street
    SW3 3NS London
    Amministratore
    4a Elystan Street
    SW3 3NS London
    United KingdomEnglishDirector81122260002
    BARNES, Andrew Nicholas Charles
    Stafford Lodge
    157 Nightingale Lane
    SW12 8NQ Wandsworth Common
    London
    Amministratore
    Stafford Lodge
    157 Nightingale Lane
    SW12 8NQ Wandsworth Common
    London
    BritishCommercial Director40919930002
    BIRKETT, Gill
    57 Turpins Rise
    GU20 6NQ Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    57 Turpins Rise
    GU20 6NQ Windlesham
    Surrey
    BritishDirector81169120001
    CARPENTER, Todd Lee
    12 Yockley Close
    GU15 1QG Camberley
    Surrey
    Amministratore
    12 Yockley Close
    GU15 1QG Camberley
    Surrey
    United KingdomUnited StatesIn Travel Industry67527580001
    CLARK, Stephen Jeffrey
    12 Forest Hills
    GU15 3NH Camberley
    Surrey
    Amministratore
    12 Forest Hills
    GU15 3NH Camberley
    Surrey
    BritishIn Travel Industry67527720001
    D'ARCY, John Lindsay
    2 Rose Cottage
    The Close
    CR4 4LS Mitcham
    Surrey
    Amministratore
    2 Rose Cottage
    The Close
    CR4 4LS Mitcham
    Surrey
    BritishDirector53392870001
    EDWARDS, Robert Kenneth
    61 Hemwood Road
    SL4 4YX Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    61 Hemwood Road
    SL4 4YX Windsor
    Berkshire
    EnglandBritishFinancial Director77876330001
    HARDING, John
    86 Drakefield Road
    Tooting
    SW17 8RR London
    Amministratore
    86 Drakefield Road
    Tooting
    SW17 8RR London
    BritishDirector106125120001
    HUGHES, Phillip Michael
    24 Friary Road
    TW19 5JP Wraysbury
    Berkshire
    Amministratore
    24 Friary Road
    TW19 5JP Wraysbury
    Berkshire
    BritishDirector64534380001
    LINDSAY, John Blackburn
    Hartfield Cottage
    Crimp Hill
    TW20 0YB Englefield Green
    Surrey
    Amministratore
    Hartfield Cottage
    Crimp Hill
    TW20 0YB Englefield Green
    Surrey
    United KingdomIrishDirector Marketing166142470002
    MILLIGAN, Nicholas Desmond Robertson
    1 Routh Road
    Wandsworth
    SW18 3SW London
    Amministratore
    1 Routh Road
    Wandsworth
    SW18 3SW London
    United KingdomBritishSales Director103905290001
    SHARMA, Sudheer Kumar
    Gable House
    Black Pond Lane
    SL2 3EN Farnham Common
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Gable House
    Black Pond Lane
    SL2 3EN Farnham Common
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishIn Travel Industry24559410002
    SKERRETT, Philip Edward
    21 Rivermead
    Hurst Road
    KT8 9AZ East Molesey
    Surrey
    Amministratore
    21 Rivermead
    Hurst Road
    KT8 9AZ East Molesey
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor3490470002
    WOOD, Nick
    3 Amyand Gardens
    TW1 3HS Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    3 Amyand Gardens
    TW1 3HS Twickenham
    Middlesex
    BritishTour Operator80937930001

    CENTURION HOLIDAY GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of deposit
    Creato il 11 mar 2004
    Consegnato il 25 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 62518569 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 giu 2003
    Consegnato il 04 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of deposit
    Creato il 15 lug 2002
    Consegnato il 30 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £40,000 credited to account designation 47374896 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 05 set 2001
    Consegnato il 07 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right,title and interest in policy no.0000270068 For £250,000 in favour of scottish mutual assurance PLC over the life of philip michael hughes; all premiums and sums payable including all bonuses/benefits thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 05 set 2001
    Consegnato il 07 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Channel 5 broadcasting limited charge agreement
    Creato il 05 set 2001
    Consegnato il 07 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility letter (as defined)
    Brevi particolari
    All of the charged property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 set 2001
    Consegnato il 07 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CENTURION HOLIDAY GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 feb 2008Inizio della liquidazione
    29 lug 2010Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven John Parker
    Tenon Recovery
    Sherlock House
    W1U 6RD 73 Baker Street
    London
    Praticante
    Tenon Recovery
    Sherlock House
    W1U 6RD 73 Baker Street
    London
    Trevor John Binyon
    Tenon Recovery
    Sherlock House
    W1U 6RD 73 Baker Street
    London
    Praticante
    Tenon Recovery
    Sherlock House
    W1U 6RD 73 Baker Street
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0