PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED

PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04086676
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CROSSCO (512) LIMITED09 ott 200009 ott 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Cessazione della carica di John Anthony Waterworth come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael John Wilmot come amministratore in data 19 lug 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 giu 2018

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Cessazione della carica di Ian Alan Bull come amministratore in data 29 giu 2018

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Risoluzione di capitalizzazione o emissione di azioni bonus

    That authority is hereby granted for the directors to capitalise and appropriate as capital the sum of £800,000 being the total amount of the company's reserves and to apply such sum in paying up in full 800,000 ordinary shares of £1.00 each in the capital of the company 20/12/2017
    RES14
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Stato del capitale al 21 dic 2017

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 20 dic 2017

    • Capitale: GBP 8,300,100
    4 pagineSH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 3 Bunhill Row London EC1Y 8YZ England a C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 3 Bunhill Row London EC1Y 8YZ

    1 pagineAD03

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    44 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Nomina di Mr Ian Alan Bull come amministratore in data 13 giu 2016

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 3 Bunhill Row London EC1Y 8YZ

    1 pagineAD02

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 gen 2016 al 31 dic 2015

    1 pagineAA01

    Risoluzioni

    Resolutions
    44 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Facilities agreement 10/11/2015
    RES13

    Chi sono gli amministratori di PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ARCHIBOLD, Judith Ann
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    British85878920001
    NORDEN, Michael Robert
    85 Neale Street
    SR6 9EY Sunderland
    Tyne & Wear
    Segretario
    85 Neale Street
    SR6 9EY Sunderland
    Tyne & Wear
    British121560410001
    DICKINSON DEES
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Segretario nominato
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    900005460001
    BAMSEY, Darrin
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish123369200006
    BULL, Ian Alan
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    England
    Amministratore
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    England
    EnglandBritish210299090001
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    Amministratore delegato nominato
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900005450001
    MCDONNELL, Bernard Neillus
    16 Malone Valley Park
    BT9 5PZ Belfast
    County Antrim
    Amministratore
    16 Malone Valley Park
    BT9 5PZ Belfast
    County Antrim
    Northern IrelandIrish123369120001
    NORDEN, Michael Robert
    85 Neale Street
    SR6 9EY Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    85 Neale Street
    SR6 9EY Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish121560410001
    WATERWORTH, John Anthony
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish203710900001
    WILMOT, Michael John
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish91108150004
    WILSON, Robert Graham
    8 Oaklands Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9PH Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Amministratore
    8 Oaklands Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9PH Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish6564660002

    Chi sono le persone con controllo significativo di PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    England
    06 apr 2016
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEnglish Law
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04086679
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 28 mar 2014
    Consegnato il 04 apr 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Intellectual property including tm 2392814, tm 2603583, tm 2604489 & tm 2604490 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Management Limited (In Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 04 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 03 mag 2006
    Consegnato il 10 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and all the other companies named in the debenture to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Crantock beach holiday park crantock beach newquay cornwall t/n CL72935,CL64619,CL58334 holywell bay holiday park holywell bay newquay cornwall t/n CL163998 and CL146183 st minver holiday park nr rock wadebridge cornwall t/n CL167364 for details of further properties charged please refer to form 395 equitable mortgage the investments in each and all of the occupational leases any hedging agreement all fixtures and fittings the accounts all monies uncalled capital floating charge all the assets property and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 10 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite debenture and guarantee
    Creato il 15 mar 2002
    Consegnato il 28 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from parkdean holidays limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Paul Anthony Yates and Jill Susan Yates
    Transazioni
    • 28 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 mar 2002
    Consegnato il 21 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from teach obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limited (As Agent and Trustee for Itself and Each Ofthe Other Finance Parties (the Security Trustee))
    Transazioni
    • 21 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 15 mar 2001
    Consegnato il 02 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilities due owing or incurred by the company formerly known as crossco (512) limited to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined) and the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Haven Leisure Limited
    Transazioni
    • 02 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplement deed to a composite guarantee and debenture dated 13TH november 1999
    Creato il 15 mar 2001
    Consegnato il 19 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and discharge all obligations and liabilities now or hereafter due, owing or incurred by the company to the secured parties or any of them and/or the chargee under or pursuant to any finance documents (all terms as defined) and all monies and discharge all obligations and liabilities due from each other company (as defined) and any other present and future subsidiary of the parent or of any company (except any obligations or liabilities of such other company as guarantor for the company concerned but including any such obligations under any negative pledge (as defined)).
    Brevi particolari
    Property being challaborough bay holiday park, title number DN175053 and DN218021, st minver holiday park, west bay holiday park os number 0065 and 0994 and paart 0086 for further details of property charged please refer to form 395. all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery. All stocks, shares, securities and other interests both present and future. All of its present and future book debts and other debts. Floating charge as a undertaking and all its property, assets and rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschilds & Sons Limited as Agent and Trustee for the Secured Parties(The "Security Agent")
    Transazioni
    • 19 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 giu 2018Inizio della liquidazione
    30 ago 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0