ELEPHANT WEST LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ELEPHANT WEST LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04089358 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ELEPHANT WEST LIMITED?
- Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere
Dove si trova ELEPHANT WEST LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Studio Building 21 Evesham Street W11 4AJ London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ELEPHANT WEST LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LETRASET LIMITED | 19 giu 2001 | 19 giu 2001 |
| CREATIVE OPPORTUNITIES LIMITED | 31 gen 2001 | 31 gen 2001 |
| LETRASET LIMITED | 09 ott 2000 | 09 ott 2000 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ELEPHANT WEST LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per ELEPHANT WEST LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 apr 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio modificato redatto al 31 dic 2017 | 19 pagine | AAMD | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 14 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Adrianus Van Schie come amministratore in data 06 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Barratt come amministratore in data 16 ago 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Jonathan Paul William Spight come amministratore in data 06 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||||||
Stato del capitale al 23 gen 2018
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 11 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2016 con aggiornamenti | 9 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Carl Hanz Brautigam come amministratore in data 02 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Carl Hanz Brautigam come amministratore in data 02 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Michael Adams come amministratore in data 31 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Michael Adams come amministratore in data 31 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di ELEPHANT WEST LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIGHT, Jonathan Paul William | Amministratore | 21 Evesham Street W11 4AJ London Studio Building | England | British | 216794410001 | |||||
| VAN SCHIE, Adrianus Hendrikus Maria | Amministratore | 21 Evesham Street W11 4AJ London Studio Building | England | Dutch | 202024180002 | |||||
| BALDOCK, Simon Paul | Segretario | Kingsnorth Industrial Estate Wotton Road TN23 6FL Ashford Kent | British | 117307130001 | ||||||
| GOTHARD, Nigel | Segretario | 3 Chaucer Mews CT2 9BF Upper Harbledown Kent | British | 77437250001 | ||||||
| PEPALL, Lewis John | Segretario | Goldthorn Road DY11 7JN Kidderminster Colart England | 175170150001 | |||||||
| BRACHERS LIMITED | Segretario | Somerfield House, 59 London Road ME16 8JH Maidstone Kent | 80957680001 | |||||||
| ADAMS, Stephen Michael | Amministratore | 21 Evesham Street W11 4AJ London Studio Building United Kingdom | England | British | 175188190001 | |||||
| BALDOCK, Simon Paul | Amministratore | Kingsnorth Industrial Estate Wotton Road TN23 6FL Ashford Kent | England | British | 117307130001 | |||||
| BARRATT, Mark | Amministratore | 21 Evesham Street W11 4AJ London Studio Building | England | British | 201080080001 | |||||
| BOWEN, Anthony David | Amministratore | Kingsnorth Industrial Estate Wotton Road TN23 6FL Ashford Kent | United Kingdom | British | 150068230001 | |||||
| BRANDON, John Robert | Amministratore | 28 Marsh Lane Mill Hill NW7 4QP London | United Kingdom | British | 99584240001 | |||||
| BRAUTIGAM, Thomas Carl Hanz | Amministratore | 21 Evesham Street W11 4AJ London Studio Building United Kingdom | United Kingdom | Swedish | 134706290001 | |||||
| GIBBS, Roy Martin | Amministratore | Kingsnorth Industrial Estate Wotton Road TN23 6FL Ashford Kent | England | British | 37073140002 | |||||
| GOTHARD, Nigel | Amministratore | 3 Chaucer Mews CT2 9BF Upper Harbledown Kent | England | British | 77437250001 | |||||
| GREGORY, Jonathan David Leigh | Amministratore | Millbeck 31 The Hordens Barns Green RH13 7PH Horsham West Sussex | England | British | 44708850001 | |||||
| HOAREAU, Guillaume | Amministratore | Kingsnorth Industrial Estate Wotton Road TN23 6FL Ashford Kent | England | French | 137444890001 | |||||
| HODGES, Simon Christopher | Amministratore | Kingsnorth Industrial Estate Wotton Road TN23 6FL Ashford Kent | England | British | 149484790001 | |||||
| JOHNSTON, Mark Frederick | Amministratore | Kingsnorth Industrial Estate Wotton Road TN23 6FL Ashford Kent | England | British | 86246750001 | |||||
| PEPALL, Lewis John | Amministratore | Goldthorn Road DY11 7JN Kidderminster Colart England | United Kingdom | British | 161095610001 | |||||
| ROPER, Gordon Edward Lawrence | Amministratore | 21 Evesham Street W11 4AJ London Studio Building United Kingdom | Great Britain | British | 120319980002 | |||||
| TRAVERS, Michael Brian | Amministratore | La-Vista 19 Temeraire Heights CT20 3TL Folkestone Kent | United Kingdom | British | 72345270002 | |||||
| WRAIGHT, Justin | Amministratore | 21 Evesham Street W11 4AJ London Studio Building United Kingdom | United Kingdom | British | 169908430001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ELEPHANT WEST LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colart International Holdings Ltd | 09 ott 2016 | Evesham Street W11 4AJ London 21 England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
ELEPHANT WEST LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creato il 09 mar 2009 Consegnato il 12 mar 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 21 lug 2006 Consegnato il 01 ago 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Porex LS1030 PWZ2 new production tool, porex LS1030 PWZ3 new production tool and dg mortimer & co LTD barrel tool new main cartridge barrel tools for details of further equipment charged please refer to form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 14 nov 2005 Consegnato il 19 nov 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 12 ott 2005 Consegnato il 15 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 06 gen 2004 Consegnato il 08 gen 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage of assurance policies | Creato il 19 giu 2001 Consegnato il 27 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company formerly known as creative opportunities limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari With full title guarantee assigns to the bank all the policy or policies of assurance described in the the schedule to the mortgage being the policy over the life of roy martin gibbs (policy number 0091202366) assuring the sum of £250,000 exclusive of bonus and the policy over the life of michael brian travers (policy number 0091201889) assuring the sum of £250,000 exclusive of bonus. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 19 giu 2001 Consegnato il 27 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company formerly known as creative opportunities limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0