ELEPHANT WEST LIMITED

ELEPHANT WEST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàELEPHANT WEST LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04089358
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ELEPHANT WEST LIMITED?

    • Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova ELEPHANT WEST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Studio Building
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ELEPHANT WEST LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LETRASET LIMITED19 giu 200119 giu 2001
    CREATIVE OPPORTUNITIES LIMITED31 gen 200131 gen 2001
    LETRASET LIMITED09 ott 200009 ott 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di ELEPHANT WEST LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per ELEPHANT WEST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio modificato redatto al 31 dic 2017

    19 pagineAAMD

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    14 pagineAA

    Nomina di Mr Adrianus Van Schie come amministratore in data 06 feb 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Barratt come amministratore in data 16 ago 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jonathan Paul William Spight come amministratore in data 06 feb 2018

    2 pagineAP01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 06 feb 2018

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Stato del capitale al 23 gen 2018

    • Capitale: GBP 1,000
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium 18/12/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2016 con aggiornamenti

    9 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 nov 2015

    Stato del capitale al 05 nov 2015

    • Capitale: GBP 483,973.43
    SH01

    Cessazione della carica di Thomas Carl Hanz Brautigam come amministratore in data 02 ott 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Thomas Carl Hanz Brautigam come amministratore in data 02 ott 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Michael Adams come amministratore in data 31 ott 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Michael Adams come amministratore in data 31 ott 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ELEPHANT WEST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SPIGHT, Jonathan Paul William
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    Amministratore
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    EnglandBritish216794410001
    VAN SCHIE, Adrianus Hendrikus Maria
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    Amministratore
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    EnglandDutch202024180002
    BALDOCK, Simon Paul
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    Segretario
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    British117307130001
    GOTHARD, Nigel
    3 Chaucer Mews
    CT2 9BF Upper Harbledown
    Kent
    Segretario
    3 Chaucer Mews
    CT2 9BF Upper Harbledown
    Kent
    British77437250001
    PEPALL, Lewis John
    Goldthorn Road
    DY11 7JN Kidderminster
    Colart
    England
    Segretario
    Goldthorn Road
    DY11 7JN Kidderminster
    Colart
    England
    175170150001
    BRACHERS LIMITED
    Somerfield House, 59 London Road
    ME16 8JH Maidstone
    Kent
    Segretario
    Somerfield House, 59 London Road
    ME16 8JH Maidstone
    Kent
    80957680001
    ADAMS, Stephen Michael
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    United Kingdom
    Amministratore
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    United Kingdom
    EnglandBritish175188190001
    BALDOCK, Simon Paul
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    Amministratore
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    EnglandBritish117307130001
    BARRATT, Mark
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    Amministratore
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    EnglandBritish201080080001
    BOWEN, Anthony David
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    Amministratore
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    United KingdomBritish150068230001
    BRANDON, John Robert
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    Amministratore
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    United KingdomBritish99584240001
    BRAUTIGAM, Thomas Carl Hanz
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    United Kingdom
    Amministratore
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    United Kingdom
    United KingdomSwedish134706290001
    GIBBS, Roy Martin
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    Amministratore
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    EnglandBritish37073140002
    GOTHARD, Nigel
    3 Chaucer Mews
    CT2 9BF Upper Harbledown
    Kent
    Amministratore
    3 Chaucer Mews
    CT2 9BF Upper Harbledown
    Kent
    EnglandBritish77437250001
    GREGORY, Jonathan David Leigh
    Millbeck 31 The Hordens
    Barns Green
    RH13 7PH Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Millbeck 31 The Hordens
    Barns Green
    RH13 7PH Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish44708850001
    HOAREAU, Guillaume
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    Amministratore
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    EnglandFrench137444890001
    HODGES, Simon Christopher
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    Amministratore
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    EnglandBritish149484790001
    JOHNSTON, Mark Frederick
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    Amministratore
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    EnglandBritish86246750001
    PEPALL, Lewis John
    Goldthorn Road
    DY11 7JN Kidderminster
    Colart
    England
    Amministratore
    Goldthorn Road
    DY11 7JN Kidderminster
    Colart
    England
    United KingdomBritish161095610001
    ROPER, Gordon Edward Lawrence
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    United Kingdom
    Amministratore
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    United Kingdom
    Great BritainBritish120319980002
    TRAVERS, Michael Brian
    La-Vista
    19 Temeraire Heights
    CT20 3TL Folkestone
    Kent
    Amministratore
    La-Vista
    19 Temeraire Heights
    CT20 3TL Folkestone
    Kent
    United KingdomBritish72345270002
    WRAIGHT, Justin
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    United Kingdom
    Amministratore
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish169908430001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ELEPHANT WEST LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Colart International Holdings Ltd
    Evesham Street
    W11 4AJ London
    21
    England
    09 ott 2016
    Evesham Street
    W11 4AJ London
    21
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleCompanies Act
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    ELEPHANT WEST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 09 mar 2009
    Consegnato il 12 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Matrix Private Equity Partners LLP
    Transazioni
    • 12 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 21 lug 2006
    Consegnato il 01 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Porex LS1030 PWZ2 new production tool, porex LS1030 PWZ3 new production tool and dg mortimer & co LTD barrel tool new main cartridge barrel tools for details of further equipment charged please refer to form 395.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 01 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 14 nov 2005
    Consegnato il 19 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 19 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 12 ott 2005
    Consegnato il 15 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 06 gen 2004
    Consegnato il 08 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 08 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of assurance policies
    Creato il 19 giu 2001
    Consegnato il 27 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as creative opportunities limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    With full title guarantee assigns to the bank all the policy or policies of assurance described in the the schedule to the mortgage being the policy over the life of roy martin gibbs (policy number 0091202366) assuring the sum of £250,000 exclusive of bonus and the policy over the life of michael brian travers (policy number 0091201889) assuring the sum of £250,000 exclusive of bonus.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank Sa-Nv UK
    Transazioni
    • 27 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 giu 2001
    Consegnato il 27 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as creative opportunities limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank Sa-Nv UK Branch
    Transazioni
    • 27 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0