CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED

CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04090240
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MWB CANNON CENTRE LEASE NO.2 LIMITED26 gen 200126 gen 2001
    IBIS (625) LIMITED13 ott 200013 ott 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Ms Lucy Baird come amministratore in data 19 giu 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christine Anne Mattimore come amministratore in data 19 giu 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Christine Anne Mattimore come amministratore in data 27 apr 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Sanne Secretaries Limited come segretario in data 27 apr 2017

    2 pagineAP04

    Nomina di Mr Anton Seatter come amministratore in data 27 apr 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian James Palmer Brown come amministratore in data 27 apr 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ross Blair come amministratore in data 27 apr 2017

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 100 New Bridge Street London EC4V 6JA a 21 Palmer Street London SW1H 0AD in data 15 mag 2017

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 040902400010 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 040902400009 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael James Topham come amministratore in data 31 dic 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    9 pagineAA

    Nomina di Ross Blair come amministratore in data 19 dic 2016

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael James Topham il 05 dic 2016

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SANNE SECRETARIES LIMITED
    Castle Street
    JE4 5UT St Helier
    13
    Jersey
    Channel Islands
    Segretario
    Castle Street
    JE4 5UT St Helier
    13
    Jersey
    Channel Islands
    Forma giuridicaPRIVATE LIMITED COMPANY
    Tipo di documento di identificazioneExtra-SEE
    Autorità legaleCOMPANIES (JERSEY) LAW 1991
    231525890001
    BAIRD, Lucy
    Castle Street
    JE4 5UT St Helier
    13
    Jersey
    Channel Islands
    Amministratore
    Castle Street
    JE4 5UT St Helier
    13
    Jersey
    Channel Islands
    JerseyBritish214316900001
    SEATTER, Anton
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    21
    England
    Amministratore
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    21
    England
    EnglandBritish231518160001
    REYNOLDS, Andrew John
    The Portobello Arms
    Chartridge Lane Chartridge
    HP5 2TF Chesham
    Buckinghamshire
    Segretario
    The Portobello Arms
    Chartridge Lane Chartridge
    HP5 2TF Chesham
    Buckinghamshire
    British70863380005
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Segretario
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    British66939460001
    DECHERT NOMINEES LIMITED
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    Segretario
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    73625410001
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Segretario
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Amministratore
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BLAIR, Ross
    Welbeck Street
    W1G 9YQ London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Welbeck Street
    W1G 9YQ London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish154858730001
    BLURTON, Andrew Francis
    Old Cedar House
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    Old Cedar House
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritish53724380001
    BROWN, Ian James Palmer
    Welbeck Street
    W1G 9YQ London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Welbeck Street
    W1G 9YQ London
    5
    United Kingdom
    EnglandBritish127801560001
    CONNOLLEY, Dominic
    151 Gladstone Road
    Wimbledon
    SW19 1QS London
    Amministratore
    151 Gladstone Road
    Wimbledon
    SW19 1QS London
    British119088700001
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    Amministratore
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritish69263980002
    JONES, Neil
    29 Langland Gardens
    NW3 6QE London
    Amministratore
    29 Langland Gardens
    NW3 6QE London
    American58464510001
    LEWIS, Philip Geoffrey
    1 Parkside
    NW7 2LJ London
    Amministratore
    1 Parkside
    NW7 2LJ London
    EnglandBritish6639590001
    MATTIMORE, Christine Anne
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    21
    England
    Amministratore
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    21
    England
    United KingdomAmerican207880160001
    MUSGRAVE, Stephen Howard Rhodes
    4 Haverfield Gardens
    Kew
    TW9 3DD Richmond
    Surrey
    Amministratore
    4 Haverfield Gardens
    Kew
    TW9 3DD Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish6981200001
    REYNOLDS, Andrew John
    The Portobello Arms
    Chartridge Lane Chartridge
    HP5 2TF Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Portobello Arms
    Chartridge Lane Chartridge
    HP5 2TF Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish70863380005
    RIDDELL, James Hendry
    17 Clearwater House
    Langley Waterside
    BR3 3GD Beckenham
    Kent
    Amministratore
    17 Clearwater House
    Langley Waterside
    BR3 3GD Beckenham
    Kent
    EnglandBritish119000220001
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Amministratore
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilian51723030002
    SINGH, Jagtar
    6 Paines Lane
    HA5 3DQ Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    6 Paines Lane
    HA5 3DQ Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish121710890001
    TOPHAM, Michael James
    Welbeck Street
    W1G 9YQ London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Welbeck Street
    W1G 9YQ London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish153072620019
    WYPER, John Stuurman
    100 New Bridge Street
    London
    EC4V 6JA
    Amministratore
    100 New Bridge Street
    London
    EC4V 6JA
    United KingdomUsa110361190007
    DECHERT NOMINEES LIMITED
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    Amministratore
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    73625410001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    78 Cannon Street Gp Limited
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    06 apr 2016
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House For England & Wales
    Numero di registrazione4411068
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 13 set 2013
    Consegnato il 30 set 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land and buildings at 78 cannon street london. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag
    Transazioni
    • 30 set 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 set 2013
    Consegnato il 30 set 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land and buildings at 78 cannon street london. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag
    Transazioni
    • 30 set 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Third party legal charge
    Creato il 11 giu 2009
    Consegnato il 15 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from 78 cannon street limited partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the l/h land and premises situate and k/a main block bush lane block and podium block situated on, over and under cannon street station cannon street london t/no. LN252045 and l/h land and premises situate at and k/a main block bush lane block and podium block situate on, over and under cannon street station cannon street london t/no. LN252857 and each and every part thereof including all rights powers easements and liberties attached inlcuding also all buildings erected including the development meaning the scheme of works to be carried out at the property of 400,000 sq ft of office accommodation over 8 storeys above mainline station na d approx 17,300 sq ft. Of retail accommodation see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Candar Finance S.A.R.L.
    Transazioni
    • 15 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Junior debenture
    Creato il 07 dic 2007
    Consegnato il 20 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch (The Agent)
    Transazioni
    • 20 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mezzanine debenture
    Creato il 26 mar 2007
    Consegnato il 30 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag,London Branch
    Transazioni
    • 30 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 mar 2007
    Consegnato il 30 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag,London Branch
    Transazioni
    • 30 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2006
    Consegnato il 22 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    78 cannon street london l/h t/no LN252045 fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital book debts buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch as Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transazioni
    • 22 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mezzanine debenture
    Creato il 12 dic 2006
    Consegnato il 22 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    78 cannon street london l/h t/no LN252045 fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital book debts buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch as Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transazioni
    • 22 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 11 lug 2002
    Consegnato il 26 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the 78 cannon street limited partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture made between mwb cannon centre no.1 Limited, mwb cannon centre no.2 Limited, mwb cannon centre lease no.1 Limited, mwb cannon centre lease no. 2 limited (1) and the chargee (2) and 3 (the "debenture")
    Creato il 15 mar 2001
    Consegnato il 20 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations due or to become due from any borrower to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as defined under (and as defined in) the credit agreement dated 16TH may 2000) under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank, London Branch
    Transazioni
    • 20 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0