CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED

CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04091152
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CEDAR UK LIMITED23 gen 200123 gen 2001
    DIPLEMA 499 LIMITED17 ott 200017 ott 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 29 nov 2013

    • Capitale: GBP 1
    6 pagineSH19

    Bilancio annuale redatto al 17 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 08/11/2013
    RES13

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Barbara Ann Firth il 11 dic 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 17 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2012

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul David Gibson il 06 set 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 17 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2011

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di Hilary Lowe come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Hilary Anne Lowe come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Mark Harry Thompson come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Gibson come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 17 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Vinodka Murria il 01 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Barbara Ann Firth il 01 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Paul David Gibson il 01 gen 2010

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2010

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FIRTH, Barbara Ann
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    BRANIFF, Edward
    19 Red Oak Lane
    FOREIGN Kinnelon
    New Jersey 07405
    Usa
    Segretario
    19 Red Oak Lane
    FOREIGN Kinnelon
    New Jersey 07405
    Usa
    Us80613310001
    GIBSON, Paul David
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Segretario
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    British192439290001
    HOSIE, Michael Douglas
    Woodbine Cottage The Long Road
    GU10 4DL Rowledge
    Surrey
    Segretario
    Woodbine Cottage The Long Road
    GU10 4DL Rowledge
    Surrey
    British23706640001
    LOWE, Hilary Anne
    Portsmouth Road
    KT11 3HQ Cobham
    Munro House
    Surrey
    Segretario
    Portsmouth Road
    KT11 3HQ Cobham
    Munro House
    Surrey
    British159479760001
    MADDOX, Adrienne Anne
    6 Heather Grove
    Hartley Wintney
    RG27 8SE Hook
    Hampshire
    Segretario
    6 Heather Grove
    Hartley Wintney
    RG27 8SE Hook
    Hampshire
    British84231690001
    TEACHEN, Sharon
    49 Arthur Road
    ME8 9BT Rainham
    Kent
    Segretario
    49 Arthur Road
    ME8 9BT Rainham
    Kent
    British72383680001
    BRANIFF, Edward
    19 Red Oak Lane
    FOREIGN Kinnelon
    New Jersey 07405
    Usa
    Amministratore
    19 Red Oak Lane
    FOREIGN Kinnelon
    New Jersey 07405
    Usa
    Us80613310001
    FRAGER, Todd
    100 E Pratt Street
    IRISH Baltimore
    Md 21202
    Usa
    Amministratore
    100 E Pratt Street
    IRISH Baltimore
    Md 21202
    Usa
    Us91869050001
    HARRISON, Michael Geoffrey
    Clive House Portsmouth Road
    KT10 9LH Esher
    Surrey
    Amministratore
    Clive House Portsmouth Road
    KT10 9LH Esher
    Surrey
    Great BritainBritish42238790001
    HOSIE, Michael Douglas
    Woodbine Cottage The Long Road
    GU10 4DL Rowledge
    Surrey
    Amministratore
    Woodbine Cottage The Long Road
    GU10 4DL Rowledge
    Surrey
    EnglandBritish23706640001
    RAINE, Colin David
    11 Chiltern Road
    SL6 1XA Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    11 Chiltern Road
    SL6 1XA Maidenhead
    Berkshire
    British74086510001
    REARDON, Jonathan Andrew
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British46067390002
    RUMP, Thomas James
    15319 Chinaberry Street
    North Potomac
    Maryland Md 20878
    Usa
    Amministratore
    15319 Chinaberry Street
    North Potomac
    Maryland Md 20878
    Usa
    American88726780001
    THOMPSON, Mark Harry
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United KingdomBritish156095450001
    TIMOTHY, Fiona Maria
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    EnglandBritish161343370001
    TIMOTHY, Fiona Maria
    Holly Cottage
    Kings Lane
    SL6 9AY Cookham Dean
    Berkshire
    Amministratore
    Holly Cottage
    Kings Lane
    SL6 9AY Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritish161343370001
    WEBSTER, Martin
    9 West Square
    SE11 4SN London
    Amministratore
    9 West Square
    SE11 4SN London
    British56348760002

    CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 mar 2007
    Consegnato il 10 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Collateral assignment
    Creato il 17 dic 2004
    Consegnato il 31 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in the subordinate tcgi pledge agreement,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Third amended and restated pledge agreement
    Creato il 17 dic 2004
    Consegnato il 31 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The pledged shares and all proceeds,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Second amended and restated pledge agreement
    Creato il 30 mag 2003
    Consegnato il 17 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the pledgor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the pledgor's right, title and interest in and to all dividends and interest on the pledged shares, all proceeds of the pledges shares and any of the other collateral, all collateral, liens and security interests, all other securities, money or other property, all other rights with respect to the foregoing collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share pledge agreement
    Creato il 15 mag 2003
    Consegnato il 23 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The pledged securities, all dividends, moneys and all other property and all cash, securities rights and interests in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 apr 2003
    Consegnato il 09 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 ott 2001
    Consegnato il 15 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0