HATCH GROUP LIMITED

HATCH GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHATCH GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04091382
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HATCH GROUP LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HATCH GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8th Floor, Holborn Gate
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HATCH GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HATCH PPS LIMITED17 gen 200117 gen 2001
    DIPLEMA 500 LIMITED17 ott 200017 ott 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di HATCH GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per HATCH GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A7KR7PCG

    legacy

    1 pagineSH20
    A7J9E615

    Stato del capitale al 26 nov 2018

    • Capitale: GBP 0.01
    5 pagineSH19
    A7J9E61L

    legacy

    1 pagineCAP-SS
    S7J9FG7N

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 15/11/2018
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X7GDRTOO

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    79 pagineAA
    L7FEX235

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X6GTL30P

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    10 pagineAA
    A6CB2QK9

    legacy

    115 paginePARENT_ACC
    A6CB2QJL

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2
    A6CB2QK1

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2
    A6CB2QJT

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X5HK45UZ

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    10 pagineAA
    A5G1W4A8

    Nomina di Mr Neil Garth Jones come amministratore in data 01 lug 2016

    2 pagineAP01
    X5COMG75

    Cessazione della carica di Rebecca Adele Horne come amministratore in data 01 lug 2016

    1 pagineTM01
    X5COMFFD

    Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor, 3 London Wall Buildings London Wall London EC2M 5SY a 8th Floor, Holborn Gate 26 Southampton Buildings London WC2A 1AN in data 04 ago 2016

    1 pagineAD01
    X5COMF4G

    Nomina di Mrs Rebecca Adele Horne come amministratore in data 31 dic 2015

    2 pagineAP01
    X4Z2L7B6

    Cessazione della carica di Samantha Williams come amministratore in data 31 dic 2015

    1 pagineTM01
    X4Z2L6UJ

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 ott 2015

    Stato del capitale al 19 ott 2015

    • Capitale: GBP 34,734.08
    SH01
    X4IC2NN6

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY England a 3rd Floor, 3 London Wall Buildings London Wall London EC2M 5SY in data 19 ott 2015

    1 pagineAD01
    X4IC2NKX

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA
    L4GH2RQ1

    legacy

    101 paginePARENT_ACC
    L4GH2RQX

    Chi sono gli amministratori di HATCH GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JONES, Neil Garth
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Amministratore
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    EnglandBritishFinance Director204774750001
    MORROW, Martin
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Amministratore
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant167225950001
    HATFIELD, Adam George Roland
    Old Berkeley Cottage
    Common Road
    WD3 5LW Chorleywood
    Hertfordshire
    Segretario
    Old Berkeley Cottage
    Common Road
    WD3 5LW Chorleywood
    Hertfordshire
    British84503340001
    LEES, Jennifer Kathryn
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    Segretario
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    British24587010002
    MCGRIGOR, Robert Angus Buchanan
    44 Endlesham Road
    SW12 8JL London
    Segretario
    44 Endlesham Road
    SW12 8JL London
    BritishDirector71640710001
    MURPHY, Michael
    Terrace House
    128 Richmond Hill, Richmond
    TW10 6RN London
    Segretario
    Terrace House
    128 Richmond Hill, Richmond
    TW10 6RN London
    BritishDirector115266830002
    TEACHEN, Sharon
    49 Arthur Road
    ME8 9BT Rainham
    Kent
    Segretario
    49 Arthur Road
    ME8 9BT Rainham
    Kent
    British72383680001
    WHITE, Jeremy Mark
    14 Parkway
    Ratton
    BN20 9DX Eastbourne
    Sussex
    Segretario
    14 Parkway
    Ratton
    BN20 9DX Eastbourne
    Sussex
    BritishChartered Accountant51297980001
    ADAMS, Colin Raymond
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    Amministratore
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    EnglandBritishFinance Director39245820011
    BLACK, Michael Norman
    Flat 2
    102 Lexham Gardens, Kensington
    W8 6JQ London
    Amministratore
    Flat 2
    102 Lexham Gardens, Kensington
    W8 6JQ London
    BritishDirector76973430001
    BROADHEAD, Tymon Piers
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    Amministratore
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    EnglandBritishAccountant105342600002
    HORNE, Rebecca Adele
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Amministratore
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    United KingdomBritishAccountant188956200001
    LEWIS, John
    27a Sloane Square
    SW1 8AD London
    Amministratore
    27a Sloane Square
    SW1 8AD London
    BritishDirector84440760001
    MACLAURIN, Brian David
    The Malt House Home Farm Close
    KT10 9HA Esher
    Surrey
    Amministratore
    The Malt House Home Farm Close
    KT10 9HA Esher
    Surrey
    BritishDirector37128720002
    MCGRIGOR, Robert Angus Buchanan
    44 Endlesham Road
    SW12 8JL London
    Amministratore
    44 Endlesham Road
    SW12 8JL London
    BritishFinance Director71640710001
    MURPHY, Michael
    Terrace House
    128 Richmond Hill, Richmond
    TW10 6RN London
    Amministratore
    Terrace House
    128 Richmond Hill, Richmond
    TW10 6RN London
    EnglandBritishDirector115266830002
    REARDON, Jonathan Andrew
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishSolicitor46067390002
    ROGERSON, Nicolas
    4 Redfield Lane
    SW5 0RG London
    Amministratore
    4 Redfield Lane
    SW5 0RG London
    EnglandBritishDirector14482390002
    SELMAN, Roger Malcolm
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    Amministratore
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    United KingdomBritishDirector10691510002
    STACE, Victoria Penelope
    Yew Tree Cottage
    Sopworth
    SN14 6PR Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    Yew Tree Cottage
    Sopworth
    SN14 6PR Chippenham
    Wiltshire
    United KingdomBritishDirector58655150001
    WEBSTER, Martin
    9 West Square
    SE11 4SN London
    Amministratore
    9 West Square
    SE11 4SN London
    BritishSolicitor56348760002
    WILLIAMS, Samantha
    c/o Grayling
    Lexington Street
    W1F 9AH London
    29-35
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Grayling
    Lexington Street
    W1F 9AH London
    29-35
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant141003360003
    WITHEY, Sally-Ann Patricia
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    Amministratore
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    EnglandBritishChief Operations Officer109428260052

    Chi sono le persone con controllo significativo di HATCH GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Huntsworth Investments Limited
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    06 apr 2016
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006 (As Amended)
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione01894682
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    HATCH GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and
    Creato il 24 apr 2007
    Consegnato il 15 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and
    Creato il 21 dic 2006
    Consegnato il 03 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004
    Creato il 16 ott 2006
    Consegnato il 20 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and
    Creato il 12 ago 2005
    Consegnato il 26 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and
    Creato il 27 lug 2005
    Consegnato il 04 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An omnibus letter of set-off
    Creato il 18 ott 2004
    Consegnato il 19 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any su or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank, either in sterling or any other currency.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of admission to an onmibus letter of set-off dated 13 july 2001
    Creato il 18 mag 2004
    Consegnato il 21 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any accounts of the companies or any of them.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 mag 2001
    Consegnato il 02 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0