FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED

FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04096014
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    West Point 501 Chester Rd
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED29 nov 200129 nov 2001
    FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED25 ott 200025 ott 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2013
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2014
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 set 2015

    9 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ England a West Point 501 Chester Rd Old Trafford Manchester M16 9HU in data 12 set 2014

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 set 2014

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da * Lancaster House Centurion Way Leyland Lancashire PR26 6TX* in data 29 mag 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 23 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 ott 2013

    Stato del capitale al 23 ott 2013

    • Capitale: GBP 1,358,129
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2012

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di John Flood come amministratore

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Sherard Secretariat Services Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Paul Birch come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Andrew Latham Nelson come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Melvyn Ewell come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian Fraser come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Arnold come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 23 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Ian Ellis Fraser come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David Llewelyn Arnold come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    10 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Gordon House Sceptre Way Bamber Bridge Preston Lancashire PR5 6AW United Kingdom* in data 31 ott 2011

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Segretario
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5615519
    109588620001
    BIRCH, Paul
    Chester Rd
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    West Point 501
    Amministratore
    Chester Rd
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    West Point 501
    United KingdomBritish76116640002
    EWELL, Melvyn
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Amministratore
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    EnglandBritish61515760002
    NELSON, Andrew Latham
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Amministratore
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    United KingdomBritish36191090003
    BIRCH, Paul
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Segretario
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    British76116640002
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Segretario
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    British36153790001
    O'MALLEY, Ann Marie
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    Segretario
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    British38211680002
    O'MALLEY, Eammon
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    Segretario
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    British25364820002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ARNOLD, David Llewelyn
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish181213200001
    BIRCH, Iain Harvey
    4 Eton Park
    PR2 9NL Preston
    Lancashire
    Amministratore
    4 Eton Park
    PR2 9NL Preston
    Lancashire
    EnglandBritish116126370001
    FLOOD, John Joseph
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish73695830003
    FRASER, Ian Ellis
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    ScotlandUk28393850006
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish36153790001
    GREENBURY, Lee
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish61478920003
    KEOGH, Sean
    Whitehead Farm
    650 Whittingham Lane Goosnargh
    PR3 2JJ Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Whitehead Farm
    650 Whittingham Lane Goosnargh
    PR3 2JJ Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish123405900001
    KIRKBY, Neil Robert Ernest
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish51438040006
    MALONEY, John Gerard
    10 Pendle Hill
    Grimsargh
    PR2 5BG Preston
    Lancashire
    Amministratore
    10 Pendle Hill
    Grimsargh
    PR2 5BG Preston
    Lancashire
    Irish96964980001
    MCGRORY, Jack
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish96596920001
    MCINNES, Randolf Graham
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish100684180001
    MCLAUGHLIN, Owen Gerard
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish17129800004
    O'MALLEY, Desmond Francis
    261 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK4 3JG Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    261 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK4 3JG Stockport
    Cheshire
    British55097840001
    O'MALLEY, Eammon
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    Amministratore
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    British25364820002
    THORNTON, James Stephen
    9 Hilly Croft
    Bromley Cross
    BL7 9HN Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    9 Hilly Croft
    Bromley Cross
    BL7 9HN Bolton
    Lancashire
    British67569070001

    FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 18 mag 2007
    Consegnato il 31 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 31 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession to a composite guarantee and mortgage debenture dated 21 august 2000 and
    Creato il 07 feb 2002
    Consegnato il 09 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property being land and buildings on the north west side of queen street, farnworth, t/no GM86886.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee Forand on Behalf of the Beneficiaries
    Transazioni
    • 09 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession to a composite guarantee and mortgage debenture dated 21 august 2000 (the "debenture deed of accession")
    Creato il 01 nov 2001
    Consegnato il 02 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys obligations and liabilities for the time due owing or incurred by the obligors (as defined therein) or any of them to any of the beneficiaries (as defined therein) including without limitation all moneys obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the financing documents (as defined) and/or on any other account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee Forand on Behalf of the Beneficaries (As Each Termis Defined in the Debenture Deed of Accession)
    Transazioni
    • 02 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 18 mag 2001
    Consegnato il 07 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement dated 18TH may 2001 and any other monies under the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Enterprise PLC
    Transazioni
    • 07 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 set 2014Inizio della liquidazione
    09 apr 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Beverley Ellice Budsworth
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    Praticante
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0