MANN + HUMMEL MCLEOD RUSSEL CLEAN AIR LIMITED

MANN + HUMMEL MCLEOD RUSSEL CLEAN AIR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMANN + HUMMEL MCLEOD RUSSEL CLEAN AIR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04103432
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MANN + HUMMEL MCLEOD RUSSEL CLEAN AIR LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MANN + HUMMEL MCLEOD RUSSEL CLEAN AIR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MANN + HUMMEL MCLEOD RUSSEL CLEAN AIR LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MCLEOD RUSSEL CLEAN AIR LIMITED09 nov 200009 nov 2000
    INGLEBY (1375) LIMITED07 nov 200007 nov 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di MANN + HUMMEL MCLEOD RUSSEL CLEAN AIR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per MANN + HUMMEL MCLEOD RUSSEL CLEAN AIR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di George Henry Black come amministratore in data 23 feb 2017

    2 pagineTM01

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 07 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 nov 2014

    Stato del capitale al 19 nov 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    12 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed mcleod russel clean air LIMITED\certificate issued on 28/03/14
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name28 mar 2014

    Risoluzione di cambio di nome della società il 04 mar 2014

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Nomina di Steffen Schneider come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thomas Blomqvist come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Thomas Blomqvist come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 07 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 nov 2013

    Stato del capitale al 20 nov 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per George Henry Black il 19 ott 2012

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per George Henry Black il 19 ott 2012

    3 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MANN + HUMMEL MCLEOD RUSSEL CLEAN AIR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SCHNEIDER, Steffen
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    GermanyGerman185882550001
    BARKER, Andrew Peter
    12 Peartree Close
    LU5 6JB Toddington
    Bedfordshire
    Segretario
    12 Peartree Close
    LU5 6JB Toddington
    Bedfordshire
    British75749380001
    BLOMQVIST, Thomas
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Segretario
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Swedish132005410001
    SOHAL, Balkar
    5 North Park
    NG18 4PA Mansfield
    Nottinghamshire
    Segretario
    5 North Park
    NG18 4PA Mansfield
    Nottinghamshire
    British122186580001
    INGLEBY NOMINEES LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Segretario nominato
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007860001
    M.R. SERVICES LIMITED
    C/O Vokes-Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Segretario
    C/O Vokes-Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    55567600012
    BLACK, George Henry
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    UkBritish151256750002
    BLOMQVIST, Thomas
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Amministratore
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Swedish132005410001
    BRICKER, Ross Benjamin
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Amministratore
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Canadian105172080001
    COTTON, Richard John
    148 Myton Road
    CV34 6PR Warwick
    Amministratore
    148 Myton Road
    CV34 6PR Warwick
    EnglandBritish45397090001
    DOHERTY, James Patrick
    950 S E 82nd Street Road
    Ocala
    Florida 34480
    Amministratore
    950 S E 82nd Street Road
    Ocala
    Florida 34480
    Irish105328280001
    FERRARI, Fabio
    Lot Chirouzanches 05240
    La Salle Les Alps
    France
    Amministratore
    Lot Chirouzanches 05240
    La Salle Les Alps
    France
    French132005120001
    FITCHFORD, Andrew Michael John
    The Old House
    The Green
    B94 5AJ Tanworth In Arden
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old House
    The Green
    B94 5AJ Tanworth In Arden
    Warwickshire
    British99141670001
    HAZLEHURST, Ian James
    Malvern Park Farm
    Widney Manor Road
    B91 3JG Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Malvern Park Farm
    Widney Manor Road
    B91 3JG Solihull
    West Midlands
    British43476760001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    The Wendy House 3 Elf Meadow
    Poulton
    GL7 5HQ Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Wendy House 3 Elf Meadow
    Poulton
    GL7 5HQ Cirencester
    Gloucestershire
    British33223550001
    KEARNEY, Christopher James
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    Amministratore
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    American85114770001
    LADENBERGER, Daniel Timothy
    24 Portland Place
    Saint Louis
    Missouri 63108
    Usa
    Amministratore
    24 Portland Place
    Saint Louis
    Missouri 63108
    Usa
    American110032170001
    LILLY, Kevin Lucius
    13515 Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Amministratore
    13515 Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican110636870001
    O'LEARY, Patrick Joseph
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Amministratore
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican61807850002
    REILLY, Michael Andrew
    2007 Channelstone Way
    NC 28104 Matthews
    Nc 28104
    Usa
    Amministratore
    2007 Channelstone Way
    NC 28104 Matthews
    Nc 28104
    Usa
    United StatesAmerican103500870001
    WALKER, Craig Allen
    Bruhnstrasse 2a
    FOREIGN 40225 Dusseldorf
    Germany
    Amministratore
    Bruhnstrasse 2a
    FOREIGN 40225 Dusseldorf
    Germany
    Usa109340980001
    WINOWIECKI, Ronald Lee
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    Amministratore
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    American95572300001
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Amministratore delegato nominato
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007850001

    MANN + HUMMEL MCLEOD RUSSEL CLEAN AIR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Share pledge agreement
    Creato il 02 ott 2008
    Consegnato il 15 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the pledgor's title to and interest in the shares see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kaupthing Bank Sverige Ab (Publ) (the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 15 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 02 ott 2008
    Consegnato il 15 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kaupthing Bank Sverige Ab Publ (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 15 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of adherence to a composite guarantee and debenture
    Creato il 20 ott 2003
    Consegnato il 28 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the security beneficiaries on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share pledge agreement
    Creato il 20 ott 2003
    Consegnato il 28 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from mcleod russel holdings PLC and certain other subsidiaries of mcleod russel holdings PLC to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares in the company and such new shares as may be issued following an increase in the company's share capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Quota pledge agreement
    Creato il 25 apr 2002
    Consegnato il 27 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the right title and interest in the quotas being the quotas of the company having a nominal value of lire 89,800,000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0