BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04104015 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2021 | 16 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 apr 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2020 | 21 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr James Michael Pinkstone il 07 ago 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 apr 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Hursh Shah come amministratore in data 03 mar 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di James Watson come amministratore in data 03 mar 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di James Andrew Honeyman come amministratore in data 03 mar 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Philip Gallier come amministratore in data 03 mar 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di David William Pilbeam come amministratore in data 03 mar 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Bruce Richardson come amministratore in data 03 mar 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Nomina di Mr Philip Gallier come amministratore in data 03 dic 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Martyn Stephen Burke come amministratore in data 03 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 2 | 2 pagine | MR05 | ||
Cessazione della carica di Dean Clegg come amministratore in data 26 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David William Pilbeam il 26 nov 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Nomina di Mr David William Pilbeam come amministratore in data 26 nov 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| COWEN, Geraint Jamie | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 141040000003 | |||||||||
| PINKSTONE, James Michael | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 241498640002 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Segretario | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Segretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ADAM, Shenol | Amministratore | 13 Beech Drive N2 9NX London | British | 2068480001 | ||||||||||
| ATKINSON, William Stephen | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 174566650001 | |||||||||
| BAGULEY, Peter Jeffrey | Amministratore | Westridge Farm Daggerridge Plain Cadeleigh EX16 8HU Tiverton Devon | United Kingdom | British | 175617500001 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Amministratore | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | 32809050004 | |||||||||
| BELL-BROWN, Philip | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 119073370001 | |||||||||
| BIRCH, John Matthew | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 191027500001 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Amministratore | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Amministratore | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | 32809000002 | |||||||||
| BURKE, Martyn Stephen | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 152531940004 | |||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Amministratore | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| CLEGG, Dean | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 189632520001 | |||||||||
| COHEN, Carolina Alfred | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 248093020001 | |||||||||
| FLEMING, Richard Alexander | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 125990210002 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Amministratore | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||||||
| FRANCIS, Luke Thomas | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 223122340001 | |||||||||
| GALLIER, Philip | Amministratore | Rutherford Heights Rodney Road SE17 1AS London 805 United Kingdom | United Kingdom | British | 265528310001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Amministratore | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| HONEYMAN, James Andrew | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 201179510001 | |||||||||
| HOORN, Antony John Van Der | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 170891040001 | |||||||||
| JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| LEARMONT, Richard John | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 116126860008 | |||||||||
| LEARMONT, Richard John | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 116126860008 | |||||||||
| LEWIS, Bryan John | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 58257940003 | |||||||||
| MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 58478890003 | |||||||||
| MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 58478890003 | |||||||||
| METLISS, Cyril | Amministratore | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 3079600001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bl Sainsbury Superstores Limited | 06 apr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed | Creato il 08 giu 2012 Consegnato il 15 giu 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The new charged shares together with all future shares or securities, rights, dividends, moneys, warrants or property paid, accruing or deriving directly or indirectly, therefrom at any time see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed | Creato il 21 giu 2010 Consegnato il 29 giu 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The new charged shares being the issued share capital of each new property company together with all shares or securities rights dividends moneys warrants or property see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 28 feb 2006 Consegnato il 13 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due of the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All its right, title and interest in and to the collateral and the shares and all dividends, interest and other income arising from any property at any time forming a part of the collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Borrower deed of charge | Creato il 28 feb 2006 Consegnato il 09 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of the shares of each property company pglc and the cash manager together with all future shares or securities rights and dividends accruing or deriving therefrom floating charge all assets not otherwise effectively mortgaged or charged. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 20 giu 2001 Consegnato il 10 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any capacity whatsoever of the borrower to the borrower secured parties under :- (a) the secured note trust deed (b) any property advisory agreement (c) the property management agreement (d) the borrower bank agreement (e) the borrower cash management agreement (f) the secured note registrar agreement and (g) clause 5 (e) of the note subscription agreement | |
Brevi particolari By way of first fixed security all of the shares of the borrower each charging company pglc and the borrower cash manager together with all future shares rights dividends monies please refer to form 395 for further details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0