BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED

BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04104015
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2021

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2020

    21 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr James Michael Pinkstone il 07 ago 2020

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Hursh Shah come amministratore in data 03 mar 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di James Watson come amministratore in data 03 mar 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di James Andrew Honeyman come amministratore in data 03 mar 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip Gallier come amministratore in data 03 mar 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David William Pilbeam come amministratore in data 03 mar 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Bruce Richardson come amministratore in data 03 mar 2020

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mr Philip Gallier come amministratore in data 03 dic 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Martyn Stephen Burke come amministratore in data 03 dic 2019

    1 pagineTM01

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 2

    2 pagineMR05

    Cessazione della carica di Dean Clegg come amministratore in data 26 nov 2019

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David William Pilbeam il 26 nov 2019

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr David William Pilbeam come amministratore in data 26 nov 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione8992198
    187856670001
    COWEN, Geraint Jamie
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritish141040000003
    PINKSTONE, James Michael
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish241498640002
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Segretario
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAM, Shenol
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    Amministratore
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    British2068480001
    ATKINSON, William Stephen
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish174566650001
    BAGULEY, Peter Jeffrey
    Westridge Farm
    Daggerridge Plain Cadeleigh
    EX16 8HU Tiverton
    Devon
    Amministratore
    Westridge Farm
    Daggerridge Plain Cadeleigh
    EX16 8HU Tiverton
    Devon
    United KingdomBritish175617500001
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Amministratore
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritish32809050004
    BELL-BROWN, Philip
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritish119073370001
    BIRCH, John Matthew
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritish191027500001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Amministratore
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritish152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Amministratore
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritish32809000002
    BURKE, Martyn Stephen
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritish152531940004
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Amministratore
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    CLEGG, Dean
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritish189632520001
    COHEN, Carolina Alfred
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish248093020001
    FLEMING, Richard Alexander
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritish125990210002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Amministratore
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritish1898090001
    FRANCIS, Luke Thomas
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish223122340001
    GALLIER, Philip
    Rutherford Heights
    Rodney Road
    SE17 1AS London
    805
    United Kingdom
    Amministratore
    Rutherford Heights
    Rodney Road
    SE17 1AS London
    805
    United Kingdom
    United KingdomBritish265528310001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Amministratore
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    British51688320001
    HONEYMAN, James Andrew
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish201179510001
    HOORN, Antony John Van Der
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritish170891040001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Amministratore
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    LEARMONT, Richard John
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritish116126860008
    LEARMONT, Richard John
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritish116126860008
    LEWIS, Bryan John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish58257940003
    MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish58478890003
    MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish58478890003
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Amministratore
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bl Sainsbury Superstores Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 apr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    BLSSP PROPERTY HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed
    Creato il 08 giu 2012
    Consegnato il 15 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The new charged shares together with all future shares or securities, rights, dividends, moneys, warrants or property paid, accruing or deriving directly or indirectly, therefrom at any time see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited (The Borrower Security Trustee)
    Transazioni
    • 15 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 lug 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 17 feb 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental deed
    Creato il 21 giu 2010
    Consegnato il 29 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The new charged shares being the issued share capital of each new property company together with all shares or securities rights dividends moneys warrants or property see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited (The Borrower Security Trustee)
    Transazioni
    • 29 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 lug 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 18 feb 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 28 feb 2006
    Consegnato il 13 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in and to the collateral and the shares and all dividends, interest and other income arising from any property at any time forming a part of the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited (The Borrower Security Trustee) on Trust for Itself and the Otherborrower Secured Parties
    Transazioni
    • 13 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 25 mag 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 17 feb 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Borrower deed of charge
    Creato il 28 feb 2006
    Consegnato il 09 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the shares of each property company pglc and the cash manager together with all future shares or securities rights and dividends accruing or deriving therefrom floating charge all assets not otherwise effectively mortgaged or charged. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited (The Borrower Security Trustee) on Trust for Itself and the Otherborrower Secured Parties
    Transazioni
    • 09 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 21 set 2016Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 25 mag 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 19 dic 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 17 feb 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge
    Creato il 20 giu 2001
    Consegnato il 10 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any capacity whatsoever of the borrower to the borrower secured parties under :- (a) the secured note trust deed (b) any property advisory agreement (c) the property management agreement (d) the borrower bank agreement (e) the borrower cash management agreement (f) the secured note registrar agreement and (g) clause 5 (e) of the note subscription agreement
    Brevi particolari
    By way of first fixed security all of the shares of the borrower each charging company pglc and the borrower cash manager together with all future shares rights dividends monies please refer to form 395 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Irg Trustees Limited in Its Capacity as the Trustee Pursuant to the Secured Note Trust Deed (The "Secured Note Trustee") on Trust for Itself and the Other Borrower Secured Parties
    Transazioni
    • 10 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0