BLSSP (PHC 3) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BLSSP (PHC 3) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04104026 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BLSSP (PHC 3) LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova BLSSP (PHC 3) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di BLSSP (PHC 3) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per BLSSP (PHC 3) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 nov 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di James Watson come amministratore in data 23 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Bruce Richardson come amministratore in data 23 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Andrew Honeyman come amministratore in data 23 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Hursh Shah come amministratore in data 23 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Dean Clegg come amministratore in data 23 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martyn Stephen Burke come amministratore in data 23 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2019 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Bruce Richardson come amministratore in data 14 giu 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Clifford Wheeler come amministratore in data 14 giu 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Stato del capitale al 05 giu 2019
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sarah Nelson come amministratore in data 14 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Clifford Wheeler come amministratore in data 14 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 4 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||
Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 2 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BLSSP (PHC 3) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| COWEN, Geraint Jamie | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 141040000003 | |||||||||
| PINKSTONE, James Michael | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 241498640001 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Segretario | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Segretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ADAM, Shenol | Amministratore | 13 Beech Drive N2 9NX London | British | 2068480001 | ||||||||||
| ATKINSON, William Stephen | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 174566650001 | |||||||||
| BAGULEY, Peter Jeffrey | Amministratore | Westridge Farm Daggerridge Plain Cadeleigh EX16 8HU Tiverton Devon | United Kingdom | British | 175617500001 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Amministratore | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | 32809050004 | |||||||||
| BELL-BROWN, Philip | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 119073370001 | |||||||||
| BIRCH, John Matthew | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 191027500001 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Amministratore | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Amministratore | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | 32809000002 | |||||||||
| BURKE, Martyn Stephen | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 152531940004 | |||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Amministratore | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| CLEGG, Dean | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 189632520001 | |||||||||
| COHEN, Carolina Alfred | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 248093020001 | |||||||||
| FLEMING, Richard Alexander | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 125990210002 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Amministratore | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||||||
| FRANCIS, Luke Thomas | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 223122340001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Amministratore | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| HONEYMAN, James Andrew | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 201179510001 | |||||||||
| HOORN, Antony John Van Der | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 170891040001 | |||||||||
| JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| LEARMONT, Richard John | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 116126860008 | |||||||||
| LEARMONT, Richard John | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 116126860008 | |||||||||
| LEWIS, Bryan John | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 58257940003 | |||||||||
| MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 58478890003 | |||||||||
| MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 58478890003 | |||||||||
| METLISS, Cyril | Amministratore | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 3079600001 | ||||||||||
| MOORE, Stephen Howard | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | 185276290002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BLSSP (PHC 3) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blssp Property Holdings Limited | 06 apr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
BLSSP (PHC 3) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed | Creato il 05 apr 2013 Consegnato il 23 apr 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land being north worle district centre queensway weston-super-mare north somerset t/no AV195696,l/h land on the west side of queens way worle weston-super-mare t/no AV88986 and f/h land and buildings on the west side of queensway worle weston-super-mare t/no ST210616 fixed charge all rental income any guarantee of rental income,its rights under any security or deposit agreement or arrangement see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Borrower deed of charge | Creato il 28 feb 2006 Acquisito il 05 apr 2013 Consegnato il 16 apr 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All rights title and interest in the existing nominee property assets see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Borrower deed of charge | Creato il 28 feb 2006 Consegnato il 09 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Please refer to form 395 for details of properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge between amongst others blssp (funding) PLC (the "borrower"), the original charging companies and capita irg trustees limited (the "secured note registrar") | Creato il 20 giu 2001 Consegnato il 06 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities of the borrower to the borrower secured parties under: (1) the secured note trust deed; (2) any property advisory agreement; (3) the property management agreement; (4) the borrower bank agreement; (5) the borrower cash management agreement; (6) the secured note registrar agreement; and (7) clause 5(e) of the note subscription agreement. All present and future obligations and liabilities of the charging companies to the borrower under clause 2.2 of the borrower deed of charge (all terms as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0