BLS NON SECURITISED 2012 2 LIMITED
Panoramica
Nome della società | BLS NON SECURITISED 2012 2 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04104066 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BLS NON SECURITISED 2012 2 LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova BLS NON SECURITISED 2012 2 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BLS NON SECURITISED 2012 2 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
BLSSP (PHC 8) LIMITED | 03 nov 2000 | 03 nov 2000 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BLS NON SECURITISED 2012 2 LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per BLS NON SECURITISED 2012 2 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 14 nov 2019
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Hursh Shah come amministratore in data 23 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Andrew Honeyman come amministratore in data 23 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Bruce Richardson come amministratore in data 23 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Dean Clegg come amministratore in data 23 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martyn Stephen Burke come amministratore in data 23 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Watson come amministratore in data 23 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Bruce Richardson come amministratore in data 14 giu 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Clifford Wheeler come amministratore in data 14 giu 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sarah Nelson come amministratore in data 14 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Clifford Wheeler come amministratore in data 14 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 nov 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr James Watson come amministratore in data 18 lug 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Carolina Cohen come amministratore in data 16 lug 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Carolina Cohen come amministratore in data 03 lug 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BLS NON SECURITISED 2012 2 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
COWEN, Geraint Jamie | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | Company Director | 141040000003 | ||||||||
PINKSTONE, James Michael | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | Corporate Finance Executive | 241498640001 | ||||||||
BRAINE, Anthony | Segretario | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||||||
EKPO, Ndiana | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
SCUDAMORE, Rebecca Jane | Segretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
ADAM, Shenol | Amministratore | 13 Beech Drive N2 9NX London | British | Company Director | 2068480001 | |||||||||
ATKINSON, William Stephen | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Surveyor | 174566650001 | ||||||||
BAGULEY, Peter Jeffrey | Amministratore | Westridge Farm Daggerridge Plain Cadeleigh EX16 8HU Tiverton Devon | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 175617500001 | ||||||||
BELL, Lucinda Margaret | Amministratore | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | Chartered Accountant | 32809050004 | ||||||||
BELL-BROWN, Philip | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | Company Director | 119073370001 | ||||||||
BIRCH, John Matthew | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 191027500001 | ||||||||
BOWDEN, Robert Edward | Amministratore | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 152497530001 | ||||||||
BRAINE, Anthony | Amministratore | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 32809000002 | ||||||||
BURKE, Martyn Stephen | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 152531940004 | ||||||||
CARTER, Simon Geoffrey | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Treasury Executive | 170891060001 | ||||||||
CLARKE, Peter Courtenay | Amministratore | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 78691990003 | ||||||||
CLEGG, Dean | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | Company Director | 189632520001 | ||||||||
COHEN, Carolina Alfred | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | Investment Executive | 248093020001 | ||||||||
FLEMING, Richard Alexander | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 125990210002 | ||||||||
FORSHAW, Christopher Michael John | Amministratore | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | Company Director | 1898090001 | ||||||||
FRANCIS, Luke Thomas | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Accountant | 223122340001 | ||||||||
GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||||||
HESTER, Stephen Alan Michael | Amministratore | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | Chief Executive | 51688320001 | |||||||||
HONEYMAN, James Andrew | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 201179510001 | ||||||||
HOORN, Antony John Van Der | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 170891040001 | ||||||||
JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | Company Director | 82020730004 | ||||||||
LEARMONT, Richard John | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 116126860008 | ||||||||
LEARMONT, Richard John | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 116126860008 | ||||||||
LEWIS, Bryan John | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 58257940003 | ||||||||
MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 58478890003 | ||||||||
MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 58478890003 | ||||||||
METLISS, Cyril | Amministratore | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | Chartered Accountant | 3079600001 | |||||||||
MOORE, Stephen Howard | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | Corporate Finance Executive | 185276290002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BLS NON SECURITISED 2012 2 LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
British Land Superstores (Non-Securitised) | 06 apr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
|
BLS NON SECURITISED 2012 2 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Supplemental deed | Creato il 23 mar 2007 Consegnato il 03 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The new charged properties fixtures insurances licences contracts rental income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Borrower deed of charge | Creato il 28 feb 2006 Consegnato il 09 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Please refer to form 395 for details of property charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge between amongst others blssp (funding) PLC (the "borrower"), the original charging companies and capita irg trustees limited (the "secured note registrar") | Creato il 20 giu 2001 Consegnato il 06 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities of the borrower to the borrower secured parties under: (1) the secured note trust deed; (2) any property advisory agreement; (3) the property management agreement; (4) the borrower bank agreement; (5) the borrower cash management agreement; (6) the secured note registrar agreement; and (7) clause 5(e) of the note subscription agreement. All present and future obligations and liabilities of the charging companies to the borrower under clause 2.2 of the borrower deed of charge (all terms as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0