UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED
Panoramica
Nome della società | UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04107035 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | The Core 40 St Thomas Street BS1 6JX Bristol |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
KINGSMANOR PROPERTIES LTD | 13 nov 2000 | 13 nov 2000 |
Quali sono gli ultimi bilanci di UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 17 nov 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 12 ott 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Joseph Julian Lister il 27 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Guy Richards il 23 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Guy Richards il 21 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Robert Szpojnarowicz il 09 set 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Robert Szpojnarowicz il 02 gen 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Christopher Robert Szjponarowicz il 09 set 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Robert Szpojnarowicz come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Robert Szjponarowicz come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Reid come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Reid come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert | Segretario | The Core 40 St Thomas Street BS1 6JX Bristol | British | 175753180001 | ||||||
ALLAN, Mark Christopher | Amministratore | The Core 40 St Thomas Street BS1 6JX Bristol | England | British | Chief Executive Officer | 74371010007 | ||||
LISTER, Joseph Julian | Amministratore | The Core 40 St Thomas Street BS1 6JX Bristol | England | British | Managing Director | 124180960001 | ||||
RICHARDS, Nicholas Guy | Amministratore | The Core 40 St Thomas Street BS1 6JX Bristol | England | British | Chartered Accountant | 122256380002 | ||||
SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert | Amministratore | The Core 40 St Thomas Street BS1 6JX Bristol | United Kingdom | British | Company Secretary/Head Of Legal | 175753180001 | ||||
FFORDE, Arthur William Brownlow | Segretario | 9 Catherine Place SW1E 6DX London | British | Chartered Accountant | 9233240002 | |||||
REID, Andrew Donald | Segretario | 15 Cranbrook Road Redland BS6 7BJ Bristol | British | Company Secretary | 67884910002 | |||||
FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Segretario nominato | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900014000001 | |||||||
BENNETT, Michael Peter | Amministratore | 45 Drakes Way Portishead BS20 6LD Bristol | England | British | Financial Controller | 86546430001 | ||||
BERNSTEIN, Simon Laurence | Amministratore | 54 Clifton Hill NW8 0QG London | United Kingdom | British | Finance Director | 76033770001 | ||||
FFORDE, Arthur William Brownlow | Amministratore | 9 Catherine Place SW1E 6DX London | British | Chartered Accountant | 9233240002 | |||||
FFORDE, Edward James Alexander | Amministratore | Holland House Little London, Albury GU5 9DG Guildford Surrey | England | British | Company Director | 14297400004 | ||||
PEARCE, Daniel Norton Idris, Sir | Amministratore | G3 Albany Piccadilly W1J 0AT London | British | Chartered Surveyor | 45656280001 | |||||
PORTER, Nicholas Anthony | Amministratore | Ridge House Horse Race Lane Failand BS8 3TX Bristol | British | Chief Executive | 45837900004 | |||||
RANSOME, David Peter | Amministratore | Silver Birches Stinchcombe Hill GL11 6AQ Dursley Gloucestershire | England | British | Chief Operating Officer | 67258390002 | ||||
REID, Andrew Donald | Amministratore | 15 Cranbrook Road Redland BS6 7BJ Bristol | United Kingdom | British | Company Secretary | 67884910002 | ||||
FORM 10 DIRECTORS FD LTD | Amministratore delegato nominato | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900013990001 |
UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 09 apr 2002 Consegnato il 19 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Including the freehold land and buildings on the west side of heald grove,rusholme,manchester; t/nos GM566761 and GM559098,GN616884 and GM593692. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 20 lug 2001 Consegnato il 25 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 20 lug 2001 Consegnato il 21 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/Hold property known as the frank taylor centre,white kirk close,rusholme,manchester. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 20 lug 2001 Consegnato il 21 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property known as part of nos.13 And 15A paradise street and nos.15,17,19,21 And 23 paradise st,coventry CV1 2JU; t/no wm 705183. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 20 lug 2001 Consegnato il 21 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property known as land and buildings on the west side of heald grove rusholme manchester and no.6 Heald grove; t/nos GM566761,GM593692,GM559098 and GM616884. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Syndicated assignment and legal charge | Creato il 28 giu 2001 Consegnato il 05 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All of the company's obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and each of the finance parties (as defined) under each of the finance documents (as defined) and on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land being north road hospital site north road aberystwyth t/no: WA889710. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 31 gen 2001 Consegnato il 13 feb 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a building contract dated 29 january 2001 | |
Brevi particolari F/H and l/h properties k/a land at kings mill lane huddersfield t/nos WYK510454 WYK351865 and WYK684349 and the proceeds of sale thereof and all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0