UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED

UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04107035
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KINGSMANOR PROPERTIES LTD13 nov 200013 nov 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 13 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 dic 2015

    Stato del capitale al 07 dic 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 17 nov 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 12 ott 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Joseph Julian Lister il 27 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Guy Richards il 23 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Guy Richards il 21 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Robert Szpojnarowicz il 09 set 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Robert Szpojnarowicz il 02 gen 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Christopher Robert Szjponarowicz il 09 set 2015

    1 pagineCH03

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 nov 2014

    Stato del capitale al 17 nov 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 nov 2013

    Stato del capitale al 25 nov 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Christopher Robert Szpojnarowicz come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Christopher Robert Szjponarowicz come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew Reid come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Reid come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 13 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    Segretario
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    British175753180001
    ALLAN, Mark Christopher
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    Amministratore
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    EnglandBritishChief Executive Officer74371010007
    LISTER, Joseph Julian
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    Amministratore
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    EnglandBritishManaging Director124180960001
    RICHARDS, Nicholas Guy
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    Amministratore
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    EnglandBritishChartered Accountant122256380002
    SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    Amministratore
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    United KingdomBritishCompany Secretary/Head Of Legal175753180001
    FFORDE, Arthur William Brownlow
    9 Catherine Place
    SW1E 6DX London
    Segretario
    9 Catherine Place
    SW1E 6DX London
    BritishChartered Accountant9233240002
    REID, Andrew Donald
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    Segretario
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    BritishCompany Secretary67884910002
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Segretario nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    BENNETT, Michael Peter
    45 Drakes Way
    Portishead
    BS20 6LD Bristol
    Amministratore
    45 Drakes Way
    Portishead
    BS20 6LD Bristol
    EnglandBritishFinancial Controller86546430001
    BERNSTEIN, Simon Laurence
    54 Clifton Hill
    NW8 0QG London
    Amministratore
    54 Clifton Hill
    NW8 0QG London
    United KingdomBritishFinance Director76033770001
    FFORDE, Arthur William Brownlow
    9 Catherine Place
    SW1E 6DX London
    Amministratore
    9 Catherine Place
    SW1E 6DX London
    BritishChartered Accountant9233240002
    FFORDE, Edward James Alexander
    Holland House
    Little London, Albury
    GU5 9DG Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Holland House
    Little London, Albury
    GU5 9DG Guildford
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director14297400004
    PEARCE, Daniel Norton Idris, Sir
    G3 Albany
    Piccadilly
    W1J 0AT London
    Amministratore
    G3 Albany
    Piccadilly
    W1J 0AT London
    BritishChartered Surveyor45656280001
    PORTER, Nicholas Anthony
    Ridge House
    Horse Race Lane Failand
    BS8 3TX Bristol
    Amministratore
    Ridge House
    Horse Race Lane Failand
    BS8 3TX Bristol
    BritishChief Executive45837900004
    RANSOME, David Peter
    Silver Birches
    Stinchcombe Hill
    GL11 6AQ Dursley
    Gloucestershire
    Amministratore
    Silver Birches
    Stinchcombe Hill
    GL11 6AQ Dursley
    Gloucestershire
    EnglandBritishChief Operating Officer67258390002
    REID, Andrew Donald
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    Amministratore
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    United KingdomBritishCompany Secretary67884910002
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Amministratore delegato nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    UNILODGE (OXNEY) 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 09 apr 2002
    Consegnato il 19 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including the freehold land and buildings on the west side of heald grove,rusholme,manchester; t/nos GM566761 and GM559098,GN616884 and GM593692. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 lug 2001
    Consegnato il 25 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 lug 2001
    Consegnato il 21 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property known as the frank taylor centre,white kirk close,rusholme,manchester. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 20 lug 2001
    Consegnato il 21 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as part of nos.13 And 15A paradise street and nos.15,17,19,21 And 23 paradise st,coventry CV1 2JU; t/no wm 705183. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 20 lug 2001
    Consegnato il 21 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as land and buildings on the west side of heald grove rusholme manchester and no.6 Heald grove; t/nos GM566761,GM593692,GM559098 and GM616884. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Syndicated assignment and legal charge
    Creato il 28 giu 2001
    Consegnato il 05 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All of the company's obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and each of the finance parties (as defined) under each of the finance documents (as defined) and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land being north road hospital site north road aberystwyth t/no: WA889710. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2001
    Consegnato il 13 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a building contract dated 29 january 2001
    Brevi particolari
    F/H and l/h properties k/a land at kings mill lane huddersfield t/nos WYK510454 WYK351865 and WYK684349 and the proceeds of sale thereof and all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery thereon.
    Persone aventi diritto
    • Aqh (Huddersfield) Limited
    Transazioni
    • 13 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0