HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04108766 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O Albany Spc Services Ltd 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CATALYST HEALTHCARE (HEXHAM) HOLDINGS LIMITED | 04 gen 2001 | 04 gen 2001 |
PEPPERGROVE LIMITED | 16 nov 2000 | 16 nov 2000 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Kenneth William Gillespie come amministratore in data 16 lug 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gregor Scott Jackson come amministratore in data 27 feb 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Johan Hendrik Potgieter come amministratore in data 27 feb 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Lend Lease, Adamson House Towers Business Park Wilmslow Road Manchester M20 2YY a C/O Albany Spc Services Ltd 3rd Floor 3-5 Charlotte Street Manchester M1 4HB in data 19 dic 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Kenneth William Gillespie il 07 nov 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ms Ailison Louise Mitchell il 07 nov 2016 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor the Venus 1 Old Park Lane Trafford Manchester M41 7HG a Lend Lease, Adamson House Towers Business Park Wilmslow Road Manchester M20 2YY in data 06 ott 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Gregor Scott Jackson come amministratore in data 26 set 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Barry Millsom come amministratore in data 26 set 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Helen Mary Murphy come amministratore in data 26 set 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 set 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITCHELL, Ailison Louise | Segretario | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | British | 53150080001 | ||||||
MCKENNA, Leo William | Amministratore | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | Northern Ireland | Northern Irish | Strategic Advisor | 164592610001 | ||||
MILLSOM, Barry Paul | Amministratore | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | Director | 190982570001 | ||||
SOLLEY, Christopher Thomas | Amministratore | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | United Kingdom | British | Director | 166666620001 | ||||
HUDSON, Alan Edmund Wilchen | Segretario | 79 Porchfield Square St John's Gardens M3 4FG Manchester | British | Company Secretary | 38798810002 | |||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
HLM SECRETARIES LIMITED | Segretario | 1st Floor 25 Stamford Street WA14 1EX Altrincham Cheshire | 118686920001 | |||||||
AMIN, Mohammed Sameer | Amministratore | 28 Talbot Road Basement Flat W2 5LJ London | England | British | Banker | 68855640001 | ||||
ANDERSON, Thomas Downs | Amministratore | 157 Percheron Drive The Mount GU21 2QX Knaphill Surrey | United Kingdom | British | Director | 54976140002 | ||||
BATE, Dennis | Amministratore | 109 Carmill Road Billinge WN5 7TY Wigan Lancashire | British | Director | 28569910001 | |||||
CHESSELLS, Arthur David, Sir | Amministratore | Oakleigh Catts Hill TN6 3NQ Mark Cross East Sussex | England | British | Director | 39000870003 | ||||
DARLING, Andrew David | Amministratore | 4 Grange Knowe EH49 7HX Linlithgow West Lothian | British | Banker | 73218540001 | |||||
DAVIS, Michael Edward | Amministratore | Alpraham Hall Barns Alpraham Green Alpraham CW6 9LJ Tarporley 1 Cheshire | England | British | Managing Director | 139286050002 | ||||
DAVIS, Michael Edward | Amministratore | Kingswater Stickling Green Clavering CB11 4QX Saffron Walden Essex | British | Director | 49577090002 | |||||
DICKIE, Timothy John | Amministratore | 51 Summerside Place EH6 4NY Edinburgh | British | Banker | 107164130002 | |||||
GANDER, Alan Keith | Amministratore | 54 Flora Thompson Drive MK16 8ST Newport Pagnell Buckinghamshire | British | Chartered Surveyor | 83045450001 | |||||
GANDER, Alan Keith | Amministratore | 54 Flora Thompson Drive MK16 8ST Newport Pagnell Buckinghamshire | British | Chartered Surveyor | 73248930001 | |||||
GILLESPIE, Kenneth William | Amministratore | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | Scotland | British | Director | 105139700001 | ||||
GRANT, Philip Robert | Amministratore | 40 Lumsdaine Drive KY11 9YU Dalgety Bay Fife | British | Banker | 76673520001 | |||||
GRANT, Stewart Chalmers | Amministratore | Chester Road HA6 1BQ Northwood 20 Middlesex | United Kingdom | British | Director | 206362380001 | ||||
HOCKADAY, Stephen | Amministratore | 33a Arterberry Road SW20 8AG London | England | British | Director | 101894100001 | ||||
HOCKADAY, Stephen | Amministratore | 33a Arterberry Road SW20 8AG London | England | British | Director | 101894100001 | ||||
JACKSON, Gregor Scott | Amministratore | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | British | Director | 191227420001 | ||||
LAYTON, Matthew Robert | Amministratore delegato nominato | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
MILLSOM, Barry Paul | Amministratore | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | England | British | Fund Manager | 156461120001 | ||||
MURPHY, Helen Mary | Amministratore | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | England | Irish | Director | 156461710001 | ||||
NEVILLE, Gary Arthur | Amministratore | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | England | British | Director | 156463000001 | ||||
PERRY, David Keith | Amministratore | Saint Leonards Road KT6 4DE Surbiton 10 Surrey | England | British | Chartered Accountant | 71558970002 | ||||
POTGIETER, Johan Hendrik | Amministratore | 3rd Floor 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | England | South African | Director | 173393140001 | ||||
POTTS, Roger Harold | Amministratore | 3rd Floor The Venus 1 Old Park Lane M41 7HG Trafford Manchester | United Kingdom | British | Quantity Surveyor | 111244220001 | ||||
POWLING, David Alan | Amministratore | 55 Calder Avenue AL9 7AH Brookmans Park Hertfordshire | United Kingdom | British | Head Of Facilities Mgt | 94649360001 | ||||
PRESCOT, Julia Elizabeth | Amministratore | 130 Thurleigh Road SW12 8TU London | British | Banker | 75494820004 | |||||
RICHARDS, Martin Edgar | Amministratore delegato nominato | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
RING, Anthony | Amministratore | 39 Mount Ararat Road TW10 6PH Richmond Surrey | British | Director | 68603350001 | |||||
SILVERBECK, Andrew David | Amministratore | The Orchard 12 Barham Avenue WD6 3PN Elstree Hertfordshire | United Kingdom | British | Accountant | 68603270002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consolidated Investment Holdings Ltd | 10 set 2016 | Towers Business Park, Wilmslow Road M20 2YY Manchester Albany Spc Services Ltd, Adamson House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Supplemental hc debenture | Creato il 27 lug 2006 Consegnato il 09 ago 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower or the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the shares being, 2 ordinary shares of £1 each in catalyst healthcare (hexham) PLC, all dividends, all moneys, bonus, uncalled capital and goodwill, by way of first floating charge its undertaking and all its assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A fixed and floating charge debenture | Creato il 27 apr 2001 Consegnato il 10 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies debts and liabilities owing or incurred by the company to any secured creditor under or in connection with any secured finance document | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0