HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED

HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04108766
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Albany Spc Services Ltd 3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CATALYST HEALTHCARE (HEXHAM) HOLDINGS LIMITED04 gen 200104 gen 2001
    PEPPERGROVE LIMITED16 nov 200016 nov 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    9 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017

    10 pagineAA

    Cessazione della carica di Kenneth William Gillespie come amministratore in data 16 lug 2018

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Gregor Scott Jackson come amministratore in data 27 feb 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Johan Hendrik Potgieter come amministratore in data 27 feb 2017

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Lend Lease, Adamson House Towers Business Park Wilmslow Road Manchester M20 2YY a C/O Albany Spc Services Ltd 3rd Floor 3-5 Charlotte Street Manchester M1 4HB in data 19 dic 2016

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kenneth William Gillespie il 07 nov 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Ailison Louise Mitchell il 07 nov 2016

    1 pagineCH03

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ott 2015

    Stato del capitale al 06 ott 2015

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor the Venus 1 Old Park Lane Trafford Manchester M41 7HG a Lend Lease, Adamson House Towers Business Park Wilmslow Road Manchester M20 2YY in data 06 ott 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    17 pagineAA

    Nomina di Mr Gregor Scott Jackson come amministratore in data 26 set 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Barry Millsom come amministratore in data 26 set 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Helen Mary Murphy come amministratore in data 26 set 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 19 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 set 2014

    Stato del capitale al 19 set 2014

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    18 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MITCHELL, Ailison Louise
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    Segretario
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    British53150080001
    MCKENNA, Leo William
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    Amministratore
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    Northern IrelandNorthern IrishStrategic Advisor164592610001
    MILLSOM, Barry Paul
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    Amministratore
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    EnglandBritishDirector190982570001
    SOLLEY, Christopher Thomas
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    Amministratore
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    United KingdomBritishDirector166666620001
    HUDSON, Alan Edmund Wilchen
    79 Porchfield Square
    St John's Gardens
    M3 4FG Manchester
    Segretario
    79 Porchfield Square
    St John's Gardens
    M3 4FG Manchester
    BritishCompany Secretary38798810002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    HLM SECRETARIES LIMITED
    1st Floor
    25 Stamford Street
    WA14 1EX Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    1st Floor
    25 Stamford Street
    WA14 1EX Altrincham
    Cheshire
    118686920001
    AMIN, Mohammed Sameer
    28 Talbot Road
    Basement Flat
    W2 5LJ London
    Amministratore
    28 Talbot Road
    Basement Flat
    W2 5LJ London
    EnglandBritishBanker68855640001
    ANDERSON, Thomas Downs
    157 Percheron Drive
    The Mount
    GU21 2QX Knaphill
    Surrey
    Amministratore
    157 Percheron Drive
    The Mount
    GU21 2QX Knaphill
    Surrey
    United KingdomBritishDirector54976140002
    BATE, Dennis
    109 Carmill Road
    Billinge
    WN5 7TY Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    109 Carmill Road
    Billinge
    WN5 7TY Wigan
    Lancashire
    BritishDirector28569910001
    CHESSELLS, Arthur David, Sir
    Oakleigh Catts Hill
    TN6 3NQ Mark Cross
    East Sussex
    Amministratore
    Oakleigh Catts Hill
    TN6 3NQ Mark Cross
    East Sussex
    EnglandBritishDirector39000870003
    DARLING, Andrew David
    4 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    West Lothian
    Amministratore
    4 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    West Lothian
    BritishBanker73218540001
    DAVIS, Michael Edward
    Alpraham Hall Barns
    Alpraham Green Alpraham
    CW6 9LJ Tarporley
    1
    Cheshire
    Amministratore
    Alpraham Hall Barns
    Alpraham Green Alpraham
    CW6 9LJ Tarporley
    1
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director139286050002
    DAVIS, Michael Edward
    Kingswater Stickling Green
    Clavering
    CB11 4QX Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Kingswater Stickling Green
    Clavering
    CB11 4QX Saffron Walden
    Essex
    BritishDirector49577090002
    DICKIE, Timothy John
    51 Summerside Place
    EH6 4NY Edinburgh
    Amministratore
    51 Summerside Place
    EH6 4NY Edinburgh
    BritishBanker107164130002
    GANDER, Alan Keith
    54 Flora Thompson Drive
    MK16 8ST Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Amministratore
    54 Flora Thompson Drive
    MK16 8ST Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    BritishChartered Surveyor83045450001
    GANDER, Alan Keith
    54 Flora Thompson Drive
    MK16 8ST Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Amministratore
    54 Flora Thompson Drive
    MK16 8ST Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    BritishChartered Surveyor73248930001
    GILLESPIE, Kenneth William
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    Amministratore
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    ScotlandBritishDirector105139700001
    GRANT, Philip Robert
    40 Lumsdaine Drive
    KY11 9YU Dalgety Bay
    Fife
    Amministratore
    40 Lumsdaine Drive
    KY11 9YU Dalgety Bay
    Fife
    BritishBanker76673520001
    GRANT, Stewart Chalmers
    Chester Road
    HA6 1BQ Northwood
    20
    Middlesex
    Amministratore
    Chester Road
    HA6 1BQ Northwood
    20
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector206362380001
    HOCKADAY, Stephen
    33a Arterberry Road
    SW20 8AG London
    Amministratore
    33a Arterberry Road
    SW20 8AG London
    EnglandBritishDirector101894100001
    HOCKADAY, Stephen
    33a Arterberry Road
    SW20 8AG London
    Amministratore
    33a Arterberry Road
    SW20 8AG London
    EnglandBritishDirector101894100001
    JACKSON, Gregor Scott
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    Amministratore
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    EnglandBritishDirector191227420001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MILLSOM, Barry Paul
    3rd Floor The Venus
    1 Old Park Lane
    M41 7HG Trafford
    Manchester
    Amministratore
    3rd Floor The Venus
    1 Old Park Lane
    M41 7HG Trafford
    Manchester
    EnglandBritishFund Manager156461120001
    MURPHY, Helen Mary
    3rd Floor The Venus
    1 Old Park Lane
    M41 7HG Trafford
    Manchester
    Amministratore
    3rd Floor The Venus
    1 Old Park Lane
    M41 7HG Trafford
    Manchester
    EnglandIrishDirector156461710001
    NEVILLE, Gary Arthur
    3rd Floor The Venus
    1 Old Park Lane
    M41 7HG Trafford
    Manchester
    Amministratore
    3rd Floor The Venus
    1 Old Park Lane
    M41 7HG Trafford
    Manchester
    EnglandBritishDirector156463000001
    PERRY, David Keith
    Saint Leonards Road
    KT6 4DE Surbiton
    10
    Surrey
    Amministratore
    Saint Leonards Road
    KT6 4DE Surbiton
    10
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant71558970002
    POTGIETER, Johan Hendrik
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    Amministratore
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    EnglandSouth AfricanDirector173393140001
    POTTS, Roger Harold
    3rd Floor The Venus
    1 Old Park Lane
    M41 7HG Trafford
    Manchester
    Amministratore
    3rd Floor The Venus
    1 Old Park Lane
    M41 7HG Trafford
    Manchester
    United KingdomBritishQuantity Surveyor111244220001
    POWLING, David Alan
    55 Calder Avenue
    AL9 7AH Brookmans Park
    Hertfordshire
    Amministratore
    55 Calder Avenue
    AL9 7AH Brookmans Park
    Hertfordshire
    United KingdomBritishHead Of Facilities Mgt94649360001
    PRESCOT, Julia Elizabeth
    130 Thurleigh Road
    SW12 8TU London
    Amministratore
    130 Thurleigh Road
    SW12 8TU London
    BritishBanker75494820004
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    RING, Anthony
    39 Mount Ararat Road
    TW10 6PH Richmond
    Surrey
    Amministratore
    39 Mount Ararat Road
    TW10 6PH Richmond
    Surrey
    BritishDirector68603350001
    SILVERBECK, Andrew David
    The Orchard
    12 Barham Avenue
    WD6 3PN Elstree
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Orchard
    12 Barham Avenue
    WD6 3PN Elstree
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant68603270002

    Chi sono le persone con controllo significativo di HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Consolidated Investment Holdings Ltd
    Towers Business Park, Wilmslow Road
    M20 2YY Manchester
    Albany Spc Services Ltd, Adamson House
    England
    10 set 2016
    Towers Business Park, Wilmslow Road
    M20 2YY Manchester
    Albany Spc Services Ltd, Adamson House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione5590097
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) hanno il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental hc debenture
    Creato il 27 lug 2006
    Consegnato il 09 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower or the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the shares being, 2 ordinary shares of £1 each in catalyst healthcare (hexham) PLC, all dividends, all moneys, bonus, uncalled capital and goodwill, by way of first floating charge its undertaking and all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured (Thesecurity Trustee)
    Transazioni
    • 09 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A fixed and floating charge debenture
    Creato il 27 apr 2001
    Consegnato il 10 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies debts and liabilities owing or incurred by the company to any secured creditor under or in connection with any secured finance document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Creditors
    Transazioni
    • 10 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0