GRS PUBS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGRS PUBS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04111631
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GRS PUBS LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari

    Dove si trova GRS PUBS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GRS PUBS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BANKSIDE PUBS LIMITED11 mag 200711 mag 2007
    BANKSIDE DEVELOPMENTS LIMITED03 mag 200103 mag 2001
    TATE TOWER LIMITED21 nov 200021 nov 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di GRS PUBS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per GRS PUBS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    18 pagineLIQ14

    Cessazione della carica di Samual Edward Kennedy come amministratore in data 08 apr 2018

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di un amministratore

    2 pagineTM01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 ago 2017

    32 pagineLIQ03

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    5 pagine4.20

    Indirizzo della sede legale modificato da 31 Haverscroft Industrial Estate New Road Attleborough Norfolk NR17 1YE a Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 14 set 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 11 ago 2016

    LRESEX

    Bilancio annuale redatto al 28 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 gen 2016

    Stato del capitale al 13 gen 2016

    • Capitale: GBP 8,405,766
    SH01

    Bilancio redatto al 28 dic 2014

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 gen 2015

    Stato del capitale al 03 gen 2015

    • Capitale: GBP 13,889,684
    SH01

    Bilancio redatto al 29 dic 2013

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 dic 2013

    Stato del capitale al 03 dic 2013

    • Capitale: GBP 13,889,684
    SH01

    Bilancio redatto al 30 dic 2012

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Bilancio redatto al 25 dic 2011

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Bilancio redatto al 26 dic 2010

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2010

    14 pagineAR01

    Bilancio redatto al 27 dic 2009

    16 pagineAA

    Cessazione della carica di Alastair Ferguson come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Ian Robinson come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di William Buchanan come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Russell Cawtheray come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di GRS PUBS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    THOMSON, Robert Keith Finlay
    Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Hill Copse 92
    Amministratore
    Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Hill Copse 92
    United KingdomBritish51167890002
    CULVER, Justin Mark
    143 Andrewes House
    Barbican
    EC2Y 8BA London
    Segretario
    143 Andrewes House
    Barbican
    EC2Y 8BA London
    British83567650001
    DODWELL, John Christopher
    Aria House
    23 Craven Street
    WC2N 5NT London
    Segretario
    Aria House
    23 Craven Street
    WC2N 5NT London
    British95741610001
    FERGUSON, Alastair William
    Haverscroft Industrial Estate
    New Road
    NR17 1YE Attleborough
    31
    Norfolk
    Segretario
    Haverscroft Industrial Estate
    New Road
    NR17 1YE Attleborough
    31
    Norfolk
    British146760260001
    LELLO, Graham
    91a Haverhill Road
    Balham
    SW12 0HE London
    Segretario
    91a Haverhill Road
    Balham
    SW12 0HE London
    South African97505870001
    MCGOURTY, Paula Kim
    68 Standen Road
    Southfields
    SW18 5TG London
    Segretario
    68 Standen Road
    Southfields
    SW18 5TG London
    British73364230001
    THORNTON, Howard
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    Segretario
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    British149837760001
    GD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Goodman Derrick
    6th Floor 90 Fetter Lane
    EC4A 1PT London
    Segretario
    Goodman Derrick
    6th Floor 90 Fetter Lane
    EC4A 1PT London
    66216820001
    BUCHANAN, Jonathan Angus
    Unstead Manor
    Trunley Heath Road Bramley
    GU5 0BW Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Unstead Manor
    Trunley Heath Road Bramley
    GU5 0BW Guildford
    Surrey
    EnglandBritish121511400002
    BUCHANAN, William Arthur Neil
    3 Westerton Court
    Clarkston
    G76 8NG Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    3 Westerton Court
    Clarkston
    G76 8NG Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish67066450003
    CAWTHERAY, Russell
    8 Shears Crescent
    CO5 8AR West Mersea
    Essex
    Amministratore
    8 Shears Crescent
    CO5 8AR West Mersea
    Essex
    British124176180001
    CROWTHER, Mark
    Randwick House
    5 Bridge Street
    NN14 3ET Brigstock
    Northamptonshire
    Amministratore
    Randwick House
    5 Bridge Street
    NN14 3ET Brigstock
    Northamptonshire
    British104967480001
    DODWELL, John Christopher
    Aria House
    23 Craven Street
    WC2N 5NT London
    Amministratore
    Aria House
    23 Craven Street
    WC2N 5NT London
    British95741610001
    GRAY, Peter Francis
    1 Bradbourne Street
    SW6 3TF London
    Amministratore
    1 Bradbourne Street
    SW6 3TF London
    United KingdomBritish4637200001
    GUNDRY, Richard
    Holgate Farm 29 The Street
    Bunwell
    NR16 1NA Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Holgate Farm 29 The Street
    Bunwell
    NR16 1NA Norwich
    Norfolk
    British107010490001
    KENNEDY, Samual Edward
    Haverscroft Industrial Estate
    New Road
    NR17 1YE Attleborough
    31
    Norfolk
    Amministratore
    Haverscroft Industrial Estate
    New Road
    NR17 1YE Attleborough
    31
    Norfolk
    EnglandBritish149343140001
    LELLO, Graham
    91a Haverhill Road
    Balham
    SW12 0HE London
    Amministratore
    91a Haverhill Road
    Balham
    SW12 0HE London
    South African97505870001
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritish57975730001
    SHARP, Kevan
    5 Mizen Close
    KT11 2RJ Cobham
    Surrey
    Amministratore
    5 Mizen Close
    KT11 2RJ Cobham
    Surrey
    British82257500001
    THORNTON, Howard
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish149837760001
    WANFORD, Matthew
    Flat 1 Bridgport Place
    SE17 1HB Wapping
    Amministratore
    Flat 1 Bridgport Place
    SE17 1HB Wapping
    British88305120002
    WILSON, Andrew Stephen
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Amministratore
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    United KingdomBritish82667700001

    GRS PUBS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge over shares
    Creato il 13 apr 2007
    Consegnato il 30 apr 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed legal charge all of its present and future rights,title and interest in and to the scheduled securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 30 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental legal charge
    Creato il 13 apr 2007
    Consegnato il 30 apr 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H bull berkhamstead herts t/no HD329381,f/h cheshire cheese warrington cheshire t/no CH443388,f/h dock south shields t/no TY350973 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Securtiy Agent")
    Transazioni
    • 30 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental legal charge
    Creato il 21 dic 2006
    Consegnato il 28 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H abinger arms guildford road abinger hammer dorking surrey t/no sy 648908,f/h alexandra 170 prsecott road fairfield liverpool t/no MS349200,f/h anchor london road bourne end hemel hempstead herts t/no HD329370 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Security Agrent")
    Transazioni
    • 28 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 30 nov 2006
    Consegnato il 06 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Anchor inn fore street chudleigh knighton f/h t/n DN318739 bell inn 180 drew street brixham f/h t/n DN313236 cheddar valley inn tusker street wells f/h t/n ST89453. For further details of property charged please refer to form 395. the security assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 06 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 31 mag 2006
    Consegnato il 13 giu 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a anchor inn fore street chudleigh knighton t/no DN318739, f/h property k/a bell inn 108 drew street brixham t/no DN313236, f/h property k/a cheddar valley inn tucker street wells t/no ST89453 for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 13 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    A security agreement
    Creato il 09 apr 2003
    Consegnato il 19 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All estates or interest in any f/h or l/h property now owned by it, all buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery on that property, and the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title of the chargor in respect of that property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • London Town PLC
    Transazioni
    • 19 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 giu 2001
    Consegnato il 30 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as 44 holland street & 47 hopton street london t/no: SGL340846. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 mag 2001
    Consegnato il 02 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GRS PUBS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 set 2018Data di scioglimento
    11 ago 2016Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Lyn L Vardy
    Central Square 8th Floor, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Praticante
    Central Square 8th Floor, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    David Christian Chubb
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0