STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED

STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04113448
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    99 City Road
    EC1Y 1AX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 nov 2015

    Stato del capitale al 20 nov 2015

    • Capitale: GBP 29,900,011
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Rich Harris come amministratore in data 29 mag 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 dic 2014

    Stato del capitale al 23 dic 2014

    • Capitale: GBP 29,900,011
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Rupert Edward Pearce come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Rich Harris come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 gen 2014

    Stato del capitale al 10 gen 2014

    • Capitale: GBP 29,900,011
    SH01

    Cessazione della carica di Rick Medlock come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Rick Charles Medlock come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian Canning come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HORROCKS, Alison Claire
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Segretario
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    British149532020001
    HORROCKS, Alison Claire
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Amministratore
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    EnglandBritish38922490004
    PEARCE, Rupert Edward
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Amministratore
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    United KingdomBritish141426110001
    BROUGH, Raymond Anthony
    Well House
    Wootton Drive, Petham
    CT4 5WD Canterbury
    Kent
    Segretario
    Well House
    Wootton Drive, Petham
    CT4 5WD Canterbury
    Kent
    British75383590001
    FITZPATRICK, Paul
    32 Kingswood Drive
    Conception
    Bay South
    Newfouldland A1w 5mi
    Segretario
    32 Kingswood Drive
    Conception
    Bay South
    Newfouldland A1w 5mi
    British85771850001
    HARRIS, Richard
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Segretario
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    American117122620002
    HOLDEN, William
    107 Codroy Place
    St Johns
    Newfoundland
    A1e 4j2
    Canada
    Segretario
    107 Codroy Place
    St Johns
    Newfoundland
    A1e 4j2
    Canada
    Canadian75104300001
    KUGELMAN, Paul Michael
    3802 Charles Street
    Alexandria
    IRISH Virginia
    22305
    Usa
    Segretario
    3802 Charles Street
    Alexandria
    IRISH Virginia
    22305
    Usa
    British114468790001
    S & J REGISTRARS LIMITED
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    Segretario
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    43122090005
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BENSON, Robert
    32 Winter Avenue
    St Johns
    A1A 1T3 Newfoundland
    Canada
    Amministratore
    32 Winter Avenue
    St Johns
    A1A 1T3 Newfoundland
    Canada
    Canadian71185940001
    BROUGH, Raymond Anthony
    Well House
    Wootton Drive, Petham
    CT4 5WD Canterbury
    Kent
    Amministratore
    Well House
    Wootton Drive, Petham
    CT4 5WD Canterbury
    Kent
    United KingdomBritish75383590001
    CANNING, Ian Alexander
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Amministratore
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    United KingdomBritish105522030004
    CIARDULLO, John Joseph
    29 Baccarat Crescent
    Brampton
    L7A 1K7 Ontario
    Canada
    Canada
    Amministratore
    29 Baccarat Crescent
    Brampton
    L7A 1K7 Ontario
    Canada
    Canada
    Canadian73063580001
    HARRIS, Rich
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Amministratore
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    EnglandAmerican184277130001
    HARRIS, Richard
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Amministratore
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    UsaAmerican117122620002
    LLOYD, Carmen
    16508 Harbour Town Drive
    Silverspring
    Maryland 20905
    Usa
    Amministratore
    16508 Harbour Town Drive
    Silverspring
    Maryland 20905
    Usa
    Canadian75441300001
    MEDLOCK, Rick Charles
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Amministratore
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    EnglandBritish181454030001
    OAKE, David J
    11 Tracey Place
    St John's
    Nl
    A1a 4t1
    Canada
    Amministratore
    11 Tracey Place
    St John's
    Nl
    A1a 4t1
    Canada
    Canadian92793820001
    PELTOLA, William Peltola
    48 Belsize Grove
    NW3 4TR London
    Amministratore
    48 Belsize Grove
    NW3 4TR London
    American75805100001
    SHENK, Maury David
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Amministratore
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    United KingdomBritish153409550001
    STURGE, Paula M
    5 Kensington Drive St Johns
    Newfoundland
    A1a 5a9
    Canada
    Amministratore
    5 Kensington Drive St Johns
    Newfoundland
    A1a 5a9
    Canada
    Canadian74592610001
    WALMSLEY, Robert, Sir
    Pagan Solicitors
    12 St Catherine Street
    KY15 4HW Cupar
    Fife
    Amministratore
    Pagan Solicitors
    12 St Catherine Street
    KY15 4HW Cupar
    Fife
    United KingdomBritish92095590003
    WOODS, Frank Derek
    750 Bay Street
    Suite 2307, Toronto
    M5G 1N6 Ontario
    Canada
    Canada
    Amministratore
    750 Bay Street
    Suite 2307, Toronto
    M5G 1N6 Ontario
    Canada
    Canada
    Canadian73063530001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of confirmation
    Creato il 13 feb 2006
    Consegnato il 03 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders or each of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The securities and the derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada Acting as Agent and as Security Trustee for Its Own Benefit as a Lenderand as Agent for the Lenders (Security Trustee)
    Transazioni
    • 03 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of confirmation
    Creato il 13 feb 2006
    Consegnato il 03 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders or each of them and all monies due or to become due from the borrowers and any of them to the lenders and the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada Acting as Agent and as Security Trustee for Its Own Benefit as a Lenderand as Agent for the Lenders (Security Trustee)
    Transazioni
    • 03 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over shares
    Creato il 03 dic 2004
    Consegnato il 18 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers (or any of them) to the security trustee and to the lenders or each of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged property proceeds of sale or other realisation, the securities and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada as Agent and Security Trustee for Its Own Benefit as a Lender and as Agentfor the Lenders (Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Note pledge agreement
    Creato il 03 dic 2004
    Consegnato il 11 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lender parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Notes means the promissory notes described in the schedule attached to from 395 and collateral means a security interest in the notes. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada (The Agent)
    Transazioni
    • 11 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Securities pledge agreement
    Creato il 03 dic 2004
    Consegnato il 11 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lender parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The securities described in the schedule attached to form 395 being any cash dividends or other moneys. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada (The Agent)
    Transazioni
    • 11 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 03 dic 2004
    Consegnato il 11 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders or each of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada Acting as Agent and as Security Trustee for Its Own Benefit as a Lenderand as Agent for the Lenders (Security Trustee)
    Transazioni
    • 11 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Note pledge agreement
    Creato il 05 gen 2001
    Consegnato il 24 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All debts liabilities and obligations of the company to the chargee (the agent) and the lenders pursuant to or in connection with the credit agreement and the other credit documents and all expenses costs and charges incurred in connection with the pledge the security interest or the realization of the collateral (all terms as defined)
    Brevi particolari
    The note which means the two promissory notes dated january 5 2001 executed by stratos global limited and the collateral means a security interest in the notes together with all right title interest and benefit of the pldgor in and to the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada
    Transazioni
    • 24 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Securities pledge agreement
    Creato il 05 gen 2001
    Consegnato il 20 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All debts, liabilities and obligations due or to become from the company to the chargee (as agent) and the lenders pursuant to or in connection with the guarantee; and the securities pledge agreement
    Brevi particolari
    The securities as defined in the pledge.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada
    Transazioni
    • 20 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over shares
    Creato il 05 gen 2001
    Consegnato il 20 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The payment and performance of all amounts owing under or pursuant to the guarantee and debenture as defined and all amounts owing under the charge from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All stocks shares warrants or other securities rights cash dividends inteerest or other property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada
    Transazioni
    • 20 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 05 gen 2001
    Consegnato il 20 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the debenture and the ontario law guarantee (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada Acting as Agent for the Lenders and as Security Trustee for Its Ownbenefit as a Lender and as Agent for the Lenders ("Security Trustee")
    Transazioni
    • 20 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0