GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED

GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04113718
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EARTHBOX LIMITED24 nov 200024 nov 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 22 dic 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 13/10/2015
    RES13

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 30 apr 2016

    1 pagineAA01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Edward Lewis il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Jonathan Ross Brodie il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Giles Henry Sharp il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 22 ott 2015

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG a Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP in data 23 ott 2015

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Jon William Mortimore come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Giles Sharp come amministratore in data 23 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Fitzsimmons come amministratore in data 12 dic 2014

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 15 dic 2014

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 24 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 nov 2014

    Stato del capitale al 24 nov 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 nov 2013

    Stato del capitale al 25 nov 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Chi sono gli amministratori di GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Segretario
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147808010001
    BRODIE, Jonathan Ross
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    EnglandBritish62279790001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    1 Martlesham
    AL7 2QF Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Segretario
    1 Martlesham
    AL7 2QF Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British72249480001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    Amministratore
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritish62279790001
    BROWN, Carole Elizabeth
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    England
    Amministratore
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    England
    EnglandBritish98235420004
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Amministratore
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Amministratore
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritish1898090001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Amministratore
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish102797820001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Amministratore
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish207729000002
    YARDLEY, Norman
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish153904770001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 11 set 2009
    Consegnato il 24 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each residential obligor to any residential secured party and from each commercial obligor to any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a and forming 159 ingram street glasgow and 97, 99, 99, an 101 hutcheson street glasgow, t/no.GLA143786 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 24 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security
    Creato il 11 set 2009
    Consegnato il 24 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each residential obligor to any residential secured party and from each commercial obligor to any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a and forming 163-167 ingram street glasgow being the basement ground and first floor premises, t/no.GLA115087 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 24 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2009
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 14 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 14 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A bond and floating charge
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 14 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each residential obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 14 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 09 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 03 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The f/h property being 190 to 196 (even numbers) and 198A kennington park road, kennington t/n SGL90575.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 03 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The f/h property k/a crown and sceptre house, bridge street, hitchin t/n HD236815.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 29 mar 2004
    Consegnato il 02 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property being land on the east side of reading road streatley t/n BK10836, land and buildings on the south side of high street streatley t/n BK10837, streatley house high street streatley t/n BK9117 for further details of the property charged please refer to the form 395. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A standard security which was presented in scotland for registration on 27 january 2004 and
    Creato il 22 gen 2004
    Consegnato il 04 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    (First) all and whole the subjects at 159 ingram street glasgow and 97, 99 and 101 hutcheson street glasgow t/n GLA143786 and (second) all and whole the subjects known as 163 to 167 ingram street glasgow t/n GLA115087.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 26 set 2003
    Consegnato il 15 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a new streets of london public house east moseley london t/n SY706112. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 18 nov 2002
    Consegnato il 23 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a greennside mills wakefield road dalton huddersfield and land and buildings lying to the south of wakefield road kirklees and land on the south side of wakefield road dalton huddersfield t/n WYK647046, WYK130371, and WYK656479. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 18 nov 2002
    Consegnato il 23 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0