SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04118859 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Innovation House Bullerthorpe Lane Colton LS15 9JL Leeds |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LANDPAINT LIMITED | 04 dic 2000 | 04 dic 2000 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr John King come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Seaton come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Raymond Christopher Foran come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Richard Daniel come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nigel Barker come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Vaughan come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 dic 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 dic 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2011 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Raymond Foran come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew David Vaughan come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2011 al 30 set 2011 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2010 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 dic 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Nigel Barker il 01 dic 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Nomina di Nigel Barker come segretario | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Lawrence come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Resourcesuite a11 Eagley Housedeakins Business Park Blackburn Roadd Egerton Bolton BL7 9RP* in data 20 lug 2010 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL, Mark Richard | Segretario | Bullerthorpe Lane Colton LS15 9JL Leeds Innovation House England | 178838900001 | |||||||
| FORAN, Raymond Christopher | Amministratore | Bullerthorpe Lane Colton LS15 9JL Leeds Innovation House England | Ireland | Irish | 149366250001 | |||||
| KING, John | Amministratore | Bullerthorpe Lane Colton LS15 9JL Leeds Innovation House | Ireland | Irish | 184461620001 | |||||
| BARKER, Nigel | Segretario | Bullerthorpe Lane Colton LS15 9JL Leeds Innovation House England | British | 153012970001 | ||||||
| HARKIN, Niall Patrick | Segretario | 5 Campbell Chase BT4 3PE Belfast County Antrim N Ireland | British | 125430560001 | ||||||
| LAWRENCE, David | Segretario | 45 Griffith Avenue Drumcondra Dublin 9 Republic Of Ireland | British | 136692630001 | ||||||
| CARILLION SECRETARIAT LIMITED | Segretario | 24 Birch Street WV1 4HY Wolverhampton West Midlands | 33743910002 | |||||||
| MOWLEM MANAGEMENT LIMITED | Segretario | White Lion Court Swan Street TW7 6RN Isleworth Middlesex | 36778210002 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BEAN, Paul Francis | Amministratore | 10 Ormiston Farm Steadings Kirknewton EH27 0DQ Edinburgh West Lothian | United Kingdom | British | 125759470001 | |||||
| BRANNIGAN, Terence Hugh | Amministratore | West Cliffe Grove HG2 0PS Harrogate 17 North Yorkshire | United Kingdom | British | 125430930001 | |||||
| DAY, Stephen John | Amministratore | Becca House Becca Lane Aberford LS25 3BD Leeds | England | British | 59028300002 | |||||
| FORAN, Raymond Christopher | Amministratore | Bullerthorpe Lane Colton LS15 9JL Leeds Innovation House England | Ireland | Irish | 149366250001 | |||||
| HARKIN, Niall Patrick | Amministratore | 5 Campbell Chase BT4 3PE Belfast County Antrim N Ireland | Northern Ireland | British | 125430560001 | |||||
| MCGRORY, Jack | Amministratore | 12 Woodlands Park Scarcroft LS14 3JU Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 96596920001 | |||||
| SEATON, David John | Amministratore | Bullerthorpe Lane Colton LS15 9JL Leeds Innovation House England | England | British | 66233040004 | |||||
| VAUGHAN, Andrew David | Amministratore | Bullerthorpe Lane Colton LS15 9JL Leeds Innovation House England | England | British | 110679680001 | |||||
| CARILLION MANAGEMENT LIMITED | Amministratore | 24 Birch Street WV1 4HY Wolverhampton West Midlands | 36778210004 | |||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creato il 28 set 2007 Consegnato il 16 ott 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0