SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED

SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04118859
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Innovation House Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LANDPAINT LIMITED04 dic 200004 dic 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 04 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 gen 2015

    Stato del capitale al 06 gen 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2013

    3 pagineAA

    Nomina di Mr John King come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Seaton come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 04 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 dic 2013

    Stato del capitale al 10 dic 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2012

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Raymond Christopher Foran come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Mark Richard Daniel come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Nigel Barker come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Andrew Vaughan come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 04 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 04 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2011

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di Raymond Foran come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew David Vaughan come amministratore

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2011 al 30 set 2011

    1 pagineAA01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2010

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Nigel Barker il 01 dic 2010

    1 pagineCH03

    Nomina di Nigel Barker come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di David Lawrence come segretario

    2 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da * Resourcesuite a11 Eagley Housedeakins Business Park Blackburn Roadd Egerton Bolton BL7 9RP* in data 20 lug 2010

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    1 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DANIEL, Mark Richard
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    England
    Segretario
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    England
    178838900001
    FORAN, Raymond Christopher
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    England
    Amministratore
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    England
    IrelandIrish149366250001
    KING, John
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    Amministratore
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    IrelandIrish184461620001
    BARKER, Nigel
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    England
    Segretario
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    England
    British153012970001
    HARKIN, Niall Patrick
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    Segretario
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    British125430560001
    LAWRENCE, David
    45 Griffith Avenue
    Drumcondra
    Dublin 9
    Republic Of Ireland
    Segretario
    45 Griffith Avenue
    Drumcondra
    Dublin 9
    Republic Of Ireland
    British136692630001
    CARILLION SECRETARIAT LIMITED
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    33743910002
    MOWLEM MANAGEMENT LIMITED
    White Lion Court
    Swan Street
    TW7 6RN Isleworth
    Middlesex
    Segretario
    White Lion Court
    Swan Street
    TW7 6RN Isleworth
    Middlesex
    36778210002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BEAN, Paul Francis
    10 Ormiston Farm Steadings
    Kirknewton
    EH27 0DQ Edinburgh
    West Lothian
    Amministratore
    10 Ormiston Farm Steadings
    Kirknewton
    EH27 0DQ Edinburgh
    West Lothian
    United KingdomBritish125759470001
    BRANNIGAN, Terence Hugh
    West Cliffe Grove
    HG2 0PS Harrogate
    17
    North Yorkshire
    Amministratore
    West Cliffe Grove
    HG2 0PS Harrogate
    17
    North Yorkshire
    United KingdomBritish125430930001
    DAY, Stephen John
    Becca House Becca Lane
    Aberford
    LS25 3BD Leeds
    Amministratore
    Becca House Becca Lane
    Aberford
    LS25 3BD Leeds
    EnglandBritish59028300002
    FORAN, Raymond Christopher
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    England
    Amministratore
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    England
    IrelandIrish149366250001
    HARKIN, Niall Patrick
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    Amministratore
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    Northern IrelandBritish125430560001
    MCGRORY, Jack
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish96596920001
    SEATON, David John
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    England
    Amministratore
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    England
    EnglandBritish66233040004
    VAUGHAN, Andrew David
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    England
    Amministratore
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    England
    EnglandBritish110679680001
    CARILLION MANAGEMENT LIMITED
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    36778210004
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    SOVEREIGN SOFT SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 28 set 2007
    Consegnato il 16 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Trustee for and on Behalf of the Finance Parties
    Transazioni
    • 16 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0