NUPHARM LABORATORIES LIMITED

NUPHARM LABORATORIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNUPHARM LABORATORIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04123795
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NUPHARM LABORATORIES LIMITED?

    • fabbricazione di prodotti farmaceutici di base (21100) / Industrie manifatturiere
    • fabbricazione di preparati farmaceutici (21200) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova NUPHARM LABORATORIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Gosforth
    Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NUPHARM LABORATORIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PHARMA FORMULATION SERVICES LIMITED12 dic 200012 dic 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di NUPHARM LABORATORIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per NUPHARM LABORATORIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    21 pagineLIQ14

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 st James Gate St. James Gate Newcastle upon Tyne NE1 4AD England a Bulman House Regent Centre Gosforth Newcastle upon Tyne NE3 3LS in data 17 lug 2020

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2020

    26 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2019

    23 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Christian Alexander Rigg come amministratore in data 05 dic 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Craig Robert Swinhoe come segretario in data 30 giu 2018

    2 pagineTM02

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineNDISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Risultato della riunione dei creditori

    6 pagineAM07

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    19 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagineAM10

    Soddisfazione dell'onere 041237950008 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    35 pagineAM03

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Quantum House Hobson Industrial Estate Burnopfield County Durham NE16 6EA a 1 st James Gate St. James Gate Newcastle upon Tyne NE1 4AD in data 27 apr 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 gen 2016

    25 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Gordon Trouton come amministratore in data 08 nov 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Catherine Jane Brown come amministratore in data 08 nov 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Brian James Fisher come amministratore in data 08 nov 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Catherine Jane Brown come amministratore in data 16 mar 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Christian Alexander Rigg come amministratore in data 08 mar 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Martin John Such come amministratore in data 08 mar 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Craig Robert Swinhoe come segretario in data 01 dic 2015

    2 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di NUPHARM LABORATORIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MATTHEWS, Andrew Paul
    Regent Centre
    NE3 3LS Gosforth
    Bulman House
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Regent Centre
    NE3 3LS Gosforth
    Bulman House
    Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish196171710001
    SANSON, David Alan
    Regent Centre
    NE3 3LS Gosforth
    Bulman House
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Regent Centre
    NE3 3LS Gosforth
    Bulman House
    Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish181607340001
    SWINHOE, Craig Robert
    St. James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    1 St James Gate
    England
    Segretario
    St. James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    1 St James Gate
    England
    205364300001
    TICKLE, Janice Mary
    38 Hatfield Gardens
    1 Appleton
    WA4 5QJ Warrington
    Cheshire
    Segretario
    38 Hatfield Gardens
    1 Appleton
    WA4 5QJ Warrington
    Cheshire
    British73620500001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Segretario nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    BARKER, Michael Denis
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    Amministratore
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    EnglandBritish160393640002
    BROWN, Catherine Jane
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    Amministratore
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    EnglandBritish206181820001
    FISHER, Brian James
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    Amministratore
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    EnglandBritish201469060001
    GOULD, William Michael
    Beacon Lane
    Heswall
    CH60 0EE Wirral
    Barnston House
    Merseyside
    England
    Amministratore
    Beacon Lane
    Heswall
    CH60 0EE Wirral
    Barnston House
    Merseyside
    England
    United KingdomBritish79479020001
    RIGG, Christian Alexander
    St. James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    1 St James Gate
    England
    Amministratore
    St. James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    1 St James Gate
    England
    United KingdomBritish202531540001
    SCAIFE, Andrew John
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    Amministratore
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    United KingdomBritish100960700008
    SUCH, Martin John
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    Amministratore
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    United KingdomBritish148239640001
    SWINHOE, Craig Robert
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    Amministratore
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    United KingdomBritish196021060001
    TICKLE, Stephen
    Beacon Lane
    Heswall
    CH60 0EE Wirral
    Barnston House
    Merseyside
    England
    Amministratore
    Beacon Lane
    Heswall
    CH60 0EE Wirral
    Barnston House
    Merseyside
    England
    United KingdomBritish73620580001
    TROUTON, Andrew Gordon
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    Amministratore
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    EnglandBritish78745040001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Amministratore delegato nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NUPHARM LABORATORIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    12 dic 2016
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06775418
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    NUPHARM LABORATORIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 13 lug 2015
    Consegnato il 27 lug 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    As more particularly described in clause 5 of the deed of accession to the debenture dated 10 july 2015, creating fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of nupharm laboratories limited.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 27 lug 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 26 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 20 giu 2013
    Consegnato il 26 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    All assets debenture
    Creato il 19 mar 2013
    Consegnato il 21 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 21 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2011
    Consegnato il 09 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Finance Wales Investments (6) Limited
    Transazioni
    • 09 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattels mortgage
    Creato il 26 feb 2010
    Consegnato il 01 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fielder pma 25/65 mixer granulator asset no:007. Gas chromatograph system 1 comprising: hewlett packard HP6890 series gc system asset:015. Hewlett packard HP6890 series injector asset no:017. For details of further chattels charged please refer to form MG01. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Genesis Asset Finance Limited
    Transazioni
    • 01 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 12 gen 2010
    Consegnato il 22 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Caleva extruder and spheroniser serial no:1329/1089, zanasi capsule filler-model LZ764 serial no:01083, sanyo gallenkamp-stability cabinet 3-25/60 deg serial no:E070046, sanyo gallenkamp-stability cabinet 4-30/65 deg serial no:E009270,microfluidiser-model M110 serial no:9012 furthermore the company convenants with the bank that during the continuance of the security it will keep the mortgaged property free from liens distress execution or other legal process.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 feb 2005
    Consegnato il 03 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 09 ago 2001
    Consegnato il 14 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NUPHARM LABORATORIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 apr 2017Inizio dell'amministrazione
    09 mag 2018Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Allan David Kelly
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    Steven Phillip Ross
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    2
    DataTipo
    09 mag 2018Inizio della liquidazione
    13 ott 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Phillip Ross
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    Allan David Kelly
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    Steven Phillip Ross
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    Allan David Kelly
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0