TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED

TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04126418
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?

    • Assicurazioni sulla vita (65110) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Evelyn Partners Llp
    45 Gresham Street
    EC2V 7BG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TILNEY GROUP LIMITED12 dic 201612 dic 2016
    YORKSHIRE INVESTMENT GROUP LIMITED15 dic 200015 dic 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 set 2022

    13 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY a C/O Evelyn Partners Llp 45 Gresham Street London EC2V 7BG in data 05 lug 2022

    2 pagineAD01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Gavin Raymond White il 14 giu 2022

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Martin Baddeley il 14 giu 2022

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Observatory Western Road Bracknell RG12 1TL United Kingdom a C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY in data 01 ott 2021

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 22 set 2021

    LRESSP

    Cessazione della carica di Deborah Ann Saunders come segretario in data 01 set 2021

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Gavin Raymond White come segretario in data 01 set 2021

    2 pagineAP03

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Nicola Claire Mitford-Slade come amministratore in data 18 dic 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Woodhouse come amministratore in data 18 dic 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Nicola Claire Mitford-Slade come amministratore in data 22 ott 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Donald William Sherret Reid come amministratore in data 22 ott 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Rehana Hasan come segretario in data 22 ott 2020

    1 pagineTM02

    Nomina di Deborah Ann Saunders come segretario in data 22 ott 2020

    2 pagineAP03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 6 Chesterfield Gardens London England W1J 5BQ England a 25 Moorgate London EC2R 6AY

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    9 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Uk Wealth Management Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WHITE, Gavin Raymond
    Gresham Street
    EC2V 7BG London
    45
    United Kingdom
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7BG London
    45
    United Kingdom
    287111660001
    BADDELEY, Andrew Martin
    Gresham Street
    EC2V 7BG London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7BG London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish82469460001
    BELLAMY, Martin William
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Segretario
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    173987280001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Segretario
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    197499510001
    HASAN, Rehana
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    Segretario
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    217675490001
    JOHNSTON, Carol Ann
    9i Calles Las Palmeras
    Urb Vista Laguna
    11312 Torreguadiaro
    Cadiz
    Spain
    Segretario
    9i Calles Las Palmeras
    Urb Vista Laguna
    11312 Torreguadiaro
    Cadiz
    Spain
    British52538020003
    NICHOLS, Sarah
    Lisbon Square
    LS1 4LY Leeds
    8
    West Yorkshire
    Segretario
    Lisbon Square
    LS1 4LY Leeds
    8
    West Yorkshire
    British157133400001
    PEACOCK, Natasha Valerie
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    Segretario
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    British129803720001
    SAUNDERS, Deborah Ann
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    England
    Segretario
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    England
    276008310001
    BRADSHAW, Phillip Gordon
    Springfield Farm
    Hardwick Road East Hardwick
    WF8 3DL Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    Springfield Farm
    Hardwick Road East Hardwick
    WF8 3DL Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritish26428400002
    BUSSEY, Michael Adrian
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    Amministratore
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    United KingdomBritish52554700003
    CHAPMAN, Andrew
    Ask House 88 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9AN Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ask House 88 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9AN Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish39777190002
    COLEMAN, Lynn Rose
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    Amministratore
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    United KingdomBritish149721950001
    CRESWELL-TURNER, Miles Marius
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    Amministratore
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    EnglandBritish160087860001
    DEVEY, Robert Alan
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish146956760001
    DOWNING, Wadham St. John
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish203301710001
    DUFTON, Jeremy Jon
    1 Long Meadow
    High Ackworth
    WF7 7EA Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Long Meadow
    High Ackworth
    WF7 7EA Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritish56706650001
    FLETCHER, Alfred Olding
    154a Western Way
    Darras Hall
    NE20 9LY Pontelant
    Northumberland
    Amministratore
    154a Western Way
    Darras Hall
    NE20 9LY Pontelant
    Northumberland
    EnglandBritish226590003
    FRASER, Thomas Aird
    Flat 3 20 Lower Sloane Street
    SW1W 8BJ London
    Amministratore
    Flat 3 20 Lower Sloane Street
    SW1W 8BJ London
    Australian74112910002
    HAINSWORTH BREAR, Timothy Austin
    Wyndorf 11a Fairway
    Tranmere Park Guiseley
    LS20 8JT Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Wyndorf 11a Fairway
    Tranmere Park Guiseley
    LS20 8JT Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish110677380001
    HALL, Peter Lindop
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish212005290001
    HERON, Hugh
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritish26428410003
    HOGG, Andrew
    6 Tranfield Gardens
    Guiseley
    LS20 8PZ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    6 Tranfield Gardens
    Guiseley
    LS20 8PZ Leeds
    West Yorkshire
    British63356910003
    JOHNSTON, Carol Ann
    Brindley House Valley Road
    Killamarsh
    S21 1JB Sheffield
    Amministratore
    Brindley House Valley Road
    Killamarsh
    S21 1JB Sheffield
    British52538020002
    JONES, Peter Francis
    15 Wigton Park Close
    LS17 8UH Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    15 Wigton Park Close
    LS17 8UH Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish33965180002
    MITFORD-SLADE, Nicola Claire
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    England
    Amministratore
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    England
    United KingdomBritish276051890001
    MULLORD, Kathleen Francis
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    Amministratore
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    United KingdomSouth African160087800001
    POLIN, Jonathan Charles
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    ScotlandBritish97840060003
    PORTEOUS, John Robert
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish166212270001
    REID, Donald William Sherret
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    Amministratore
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    EnglandBritish212004930001
    SAWYER, Gareth Matthew
    5 Chelmsford Road
    HG1 5NA Harrogate
    Amministratore
    5 Chelmsford Road
    HG1 5NA Harrogate
    United KingdomBritish46468670003
    SINCLAIR, Richard Harris
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    Amministratore
    Ropergate House 43 Ropergate
    Pontefract
    WF8 1JY West Yorkshire
    EnglandBritish204668540001
    TAGLIABUE, Alfio
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    United KingdomItalian76352220004
    WOODHOUSE, Christopher
    Chesterfield Gardens
    W1J 5BQ London
    6
    England
    England
    Amministratore
    Chesterfield Gardens
    W1J 5BQ London
    6
    England
    England
    EnglandBritish238888480001
    WRIGHT, Paul Vernon
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish137936580001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4438652
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 04 giu 2015
    Consegnato il 11 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 22 ott 2002
    Consegnato il 29 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Policy no RNF00072345A for £200,000 over life of phillip gordon bradshaw with all sums,bonuses and benefits thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 22 ott 2002
    Consegnato il 29 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Policy no RNF0072346A for £200,000 over life of hugh heron with all bonuses and benefits thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 22 ott 2002
    Consegnato il 29 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Policy no RNF0072342A for £200,000 over life of andrew hogg with all sums,bonuses and benefits thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 22 ott 2002
    Consegnato il 29 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Policy no RNF0072344A for £200,000 over life of peter francis jones with all sums,bonuses and benefits thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 02 ott 2002
    Consegnato il 17 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Licence to assign
    Creato il 27 nov 2001
    Consegnato il 28 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and media works corporation communications LTD to the chargee pursuant to the licence to assign
    Brevi particolari
    The sum of £10,350.00 plus vat the account in which the sum is deposited and all sums from time to time standing to the credit of the account.
    Persone aventi diritto
    • Roxburgh Holdings Limited
    Transazioni
    • 28 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 28 feb 2001
    Consegnato il 06 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 set 2021Inizio della liquidazione
    14 set 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Henry Anthony Shinners
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Praticante
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Clare Lloyd
    25 Moorgate
    Surrey
    EC2R 6AY London
    Praticante
    25 Moorgate
    Surrey
    EC2R 6AY London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0