TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04126418 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?
- Assicurazioni sulla vita (65110) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Evelyn Partners Llp 45 Gresham Street EC2V 7BG London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TILNEY GROUP LIMITED | 12 dic 2016 | 12 dic 2016 |
| YORKSHIRE INVESTMENT GROUP LIMITED | 15 dic 2000 | 15 dic 2000 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 12 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 set 2022 | 13 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY a C/O Evelyn Partners Llp 45 Gresham Street London EC2V 7BG in data 05 lug 2022 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Gavin Raymond White il 14 giu 2022 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Martin Baddeley il 14 giu 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Observatory Western Road Bracknell RG12 1TL United Kingdom a C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY in data 01 ott 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Deborah Ann Saunders come segretario in data 01 set 2021 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Gavin Raymond White come segretario in data 01 set 2021 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicola Claire Mitford-Slade come amministratore in data 18 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Woodhouse come amministratore in data 18 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Nicola Claire Mitford-Slade come amministratore in data 22 ott 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Donald William Sherret Reid come amministratore in data 22 ott 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Rehana Hasan come segretario in data 22 ott 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Deborah Ann Saunders come segretario in data 22 ott 2020 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 6 Chesterfield Gardens London England W1J 5BQ England a 25 Moorgate London EC2R 6AY | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Uk Wealth Management Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE, Gavin Raymond | Segretario | Gresham Street EC2V 7BG London 45 United Kingdom | 287111660001 | |||||||
| BADDELEY, Andrew Martin | Amministratore | Gresham Street EC2V 7BG London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 82469460001 | |||||
| BELLAMY, Martin William | Segretario | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | 173987280001 | |||||||
| GREGORY, Jacqueline Anne | Segretario | c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | 197499510001 | |||||||
| HASAN, Rehana | Segretario | Western Road RG12 1TL Bracknell The Observatory United Kingdom | 217675490001 | |||||||
| JOHNSTON, Carol Ann | Segretario | 9i Calles Las Palmeras Urb Vista Laguna 11312 Torreguadiaro Cadiz Spain | British | 52538020003 | ||||||
| NICHOLS, Sarah | Segretario | Lisbon Square LS1 4LY Leeds 8 West Yorkshire | British | 157133400001 | ||||||
| PEACOCK, Natasha Valerie | Segretario | Pear Tree Drive SK15 2PY Stalybridge 7 Cheshire | British | 129803720001 | ||||||
| SAUNDERS, Deborah Ann | Segretario | Moorgate EC2R 6AY London 25 England | 276008310001 | |||||||
| BRADSHAW, Phillip Gordon | Amministratore | Springfield Farm Hardwick Road East Hardwick WF8 3DL Pontefract West Yorkshire | United Kingdom | British | 26428400002 | |||||
| BUSSEY, Michael Adrian | Amministratore | Ropergate House 43 Ropergate Pontefract WF8 1JY West Yorkshire | United Kingdom | British | 52554700003 | |||||
| CHAPMAN, Andrew | Amministratore | Ask House 88 Leeds Road Bramhope LS16 9AN Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 39777190002 | |||||
| COLEMAN, Lynn Rose | Amministratore | Ropergate House 43 Ropergate Pontefract WF8 1JY West Yorkshire | United Kingdom | British | 149721950001 | |||||
| CRESWELL-TURNER, Miles Marius | Amministratore | Ropergate House 43 Ropergate Pontefract WF8 1JY West Yorkshire | England | British | 160087860001 | |||||
| DEVEY, Robert Alan | Amministratore | c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | United Kingdom | British | 146956760001 | |||||
| DOWNING, Wadham St. John | Amministratore | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 203301710001 | |||||
| DUFTON, Jeremy Jon | Amministratore | 1 Long Meadow High Ackworth WF7 7EA Pontefract West Yorkshire | United Kingdom | British | 56706650001 | |||||
| FLETCHER, Alfred Olding | Amministratore | 154a Western Way Darras Hall NE20 9LY Pontelant Northumberland | England | British | 226590003 | |||||
| FRASER, Thomas Aird | Amministratore | Flat 3 20 Lower Sloane Street SW1W 8BJ London | Australian | 74112910002 | ||||||
| HAINSWORTH BREAR, Timothy Austin | Amministratore | Wyndorf 11a Fairway Tranmere Park Guiseley LS20 8JT Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 110677380001 | |||||
| HALL, Peter Lindop | Amministratore | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 212005290001 | |||||
| HERON, Hugh | Amministratore | 114 Carleton Road WF8 3NQ Pontefract West Yorkshire | England | British | 26428410003 | |||||
| HOGG, Andrew | Amministratore | 6 Tranfield Gardens Guiseley LS20 8PZ Leeds West Yorkshire | British | 63356910003 | ||||||
| JOHNSTON, Carol Ann | Amministratore | Brindley House Valley Road Killamarsh S21 1JB Sheffield | British | 52538020002 | ||||||
| JONES, Peter Francis | Amministratore | 15 Wigton Park Close LS17 8UH Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 33965180002 | |||||
| MITFORD-SLADE, Nicola Claire | Amministratore | Moorgate EC2R 6AY London 25 England | United Kingdom | British | 276051890001 | |||||
| MULLORD, Kathleen Francis | Amministratore | Ropergate House 43 Ropergate Pontefract WF8 1JY West Yorkshire | United Kingdom | South African | 160087800001 | |||||
| POLIN, Jonathan Charles | Amministratore | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | Scotland | British | 97840060003 | |||||
| PORTEOUS, John Robert | Amministratore | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 166212270001 | |||||
| REID, Donald William Sherret | Amministratore | Western Road RG12 1TL Bracknell The Observatory United Kingdom | England | British | 212004930001 | |||||
| SAWYER, Gareth Matthew | Amministratore | 5 Chelmsford Road HG1 5NA Harrogate | United Kingdom | British | 46468670003 | |||||
| SINCLAIR, Richard Harris | Amministratore | Ropergate House 43 Ropergate Pontefract WF8 1JY West Yorkshire | England | British | 204668540001 | |||||
| TAGLIABUE, Alfio | Amministratore | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | United Kingdom | Italian | 76352220004 | |||||
| WOODHOUSE, Christopher | Amministratore | Chesterfield Gardens W1J 5BQ London 6 England England | England | British | 238888480001 | |||||
| WRIGHT, Paul Vernon | Amministratore | c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | United Kingdom | British | 137936580001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uk Wealth Management Limited | 06 apr 2016 | Western Road RG12 1TL Bracknell The Observatory United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 04 giu 2015 Consegnato il 11 giu 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Creato il 22 ott 2002 Consegnato il 29 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Policy no RNF00072345A for £200,000 over life of phillip gordon bradshaw with all sums,bonuses and benefits thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Creato il 22 ott 2002 Consegnato il 29 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Policy no RNF0072346A for £200,000 over life of hugh heron with all bonuses and benefits thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Creato il 22 ott 2002 Consegnato il 29 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Policy no RNF0072342A for £200,000 over life of andrew hogg with all sums,bonuses and benefits thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Creato il 22 ott 2002 Consegnato il 29 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Policy no RNF0072344A for £200,000 over life of peter francis jones with all sums,bonuses and benefits thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 02 ott 2002 Consegnato il 17 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Licence to assign | Creato il 27 nov 2001 Consegnato il 28 nov 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and media works corporation communications LTD to the chargee pursuant to the licence to assign | |
Brevi particolari The sum of £10,350.00 plus vat the account in which the sum is deposited and all sums from time to time standing to the credit of the account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture deed | Creato il 28 feb 2001 Consegnato il 06 mar 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0