K P GENERAL PARTNER LIMITED

K P GENERAL PARTNER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàK P GENERAL PARTNER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04129627
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di K P GENERAL PARTNER LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova K P GENERAL PARTNER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    81 Cromwell Road
    SW7 5BW London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di K P GENERAL PARTNER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DWSCO 2122 LIMITED21 dic 200021 dic 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di K P GENERAL PARTNER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per K P GENERAL PARTNER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Valsec Company Secretarial Services Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 dic 2010

    Stato del capitale al 29 dic 2010

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Valsec Company Secretarial Services Limited come segretario

    3 pagineAP04

    Cessazione della carica di Valad Secretarial Services Limited come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2008 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2007 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Valad Secretarial Services Limited il 21 dic 2009

    2 pagineCH04

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2008 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon John Patrick Lear il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Nicholas Balchin il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2008

    1 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    2 pagine288c

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    1 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2006

    1 pagineAA

    legacy

    3 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di K P GENERAL PARTNER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BALCHIN, Mark Nicholas
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Amministratore
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    UkBritish812680001
    LEAR, Simon John Patrick
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Amministratore
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    United KingdomBritish138750860001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Segretario
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    British812680001
    DWS SECRETARIES LIMITED
    5 Chancery Lane
    WC2A 1LF London
    Segretario nominato
    5 Chancery Lane
    WC2A 1LF London
    900020220001
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    United Kingdom
    Segretario
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC219311
    133355520001
    VALSEC COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Segretario
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione7307485
    154205080001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    VAN REYK, Philip
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    Amministratore
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    EnglandBritish76943220003
    DWS DIRECTORS LIMITED
    5 Chancery Lane
    WC2A 1LF London
    Amministratore delegato nominato
    5 Chancery Lane
    WC2A 1LF London
    900020210001

    K P GENERAL PARTNER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 06 mar 2002
    Consegnato il 12 mar 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 57-59 cromwell road london t/n NGL377987. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 11 set 2001
    Consegnato il 25 set 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 57-59 cromwell road london t/no: NGL377987. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Equitable charge
    Creato il 02 mag 2001
    Consegnato il 12 mag 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H properties being 67 charlesworth house and garage 48, 77 charlesworth house and garage 51, 85 charlesworth house and garage 53 and 87 charlesworth house and garage 68 all at 46-52 stanhope gardens kensington and chelsea t/nos: BGL27244 BGL27220 BGL27222 and BGL27224. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 2001
    Consegnato il 12 mag 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as 57-79 cromwell road london title number NGL377987 all buildings and other structures all plant machinery by way of an assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 02 mag 2001
    Consegnato il 12 mag 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or partnership (as defined) to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0