HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC LIMITED

HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04130538
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC LIMITED?

    • Attività ospedaliere (86101) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Suite 3 Regency House
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC PLC20 lug 201120 lug 2011
    CATALYST HEALTHCARE (HEXHAM) PLC19 dic 200019 dic 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    12 pagineLIQ14

    Cessazione della carica di Kenneth William Gillespie come amministratore in data 16 lug 2018

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Albany Spc Services Ltd 3rd Floor 3-5 Charlotte Street Manchester M1 4HB England a Suite 3 Regency House 91 Western Road Brighton BN1 2NW in data 23 feb 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    8 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 09 feb 2018

    LRESEX

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kenneth William Gillespie il 09 mar 2017

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Johan Hendrik Potgieter come amministratore in data 27 feb 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gregor Scott Jackson come amministratore in data 27 feb 2017

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Lend Lease, Adamson House Towers Business Park Wilmslow Road Manchester M20 2YY a C/O Albany Spc Services Ltd 3rd Floor 3-5 Charlotte Street Manchester M1 4HB in data 19 dic 2016

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    22 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ott 2015

    Stato del capitale al 06 ott 2015

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor the Venus 1 Old Park Lane Trafford Manchester M41 7HG a Lend Lease, Adamson House Towers Business Park Wilmslow Road Manchester M20 2YY in data 06 ott 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    21 pagineAA

    Certificato di ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata

    1 pagineCERT10

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    20 pagineMAR

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di ri-registrazione

    RES02

    Riregistrazione da società pubblica a società a responsabilità limitata privata

    2 pagineRR02

    Nomina di Mr Gregor Scott Jackson come amministratore in data 26 set 2014

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MITCHELL, Ailison Louise
    16 Heatley Close
    Denton
    M34 2JD Manchester
    Lancashire
    Segretario
    16 Heatley Close
    Denton
    M34 2JD Manchester
    Lancashire
    British53150080001
    MCKENNA, Leo William
    Regency House
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    Suite 3
    Amministratore
    Regency House
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    Suite 3
    Northern IrelandNorthern Irish164592610001
    MILLSOM, Barry Paul
    Regency House
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    Suite 3
    Amministratore
    Regency House
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    Suite 3
    EnglandBritish190982570001
    SOLLEY, Christopher Thomas
    Regency House
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    Suite 3
    Amministratore
    Regency House
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    Suite 3
    United KingdomBritish166666620001
    HUDSON, Alan Edmund Wilchen
    79 Porchfield Square
    St John's Gardens
    M3 4FG Manchester
    Segretario
    79 Porchfield Square
    St John's Gardens
    M3 4FG Manchester
    British38798810002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4JJ London
    Segretario
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4JJ London
    38508390002
    HLM SECRETARIES LIMITED
    1st Floor
    25 Stamford Street
    WA14 1EX Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    1st Floor
    25 Stamford Street
    WA14 1EX Altrincham
    Cheshire
    118686920001
    AMIN, Mohammed Sameer
    28 Talbot Road
    Basement Flat
    W2 5LJ London
    Amministratore
    28 Talbot Road
    Basement Flat
    W2 5LJ London
    EnglandBritish68855640001
    ANDERSON, Thomas Downs
    157 Percheron Drive
    The Mount
    GU21 2QX Knaphill
    Surrey
    Amministratore
    157 Percheron Drive
    The Mount
    GU21 2QX Knaphill
    Surrey
    United KingdomBritish54976140002
    ANDERSON, Thomas Downs
    157 Percheron Drive
    The Mount
    GU21 2QX Knaphill
    Surrey
    Amministratore
    157 Percheron Drive
    The Mount
    GU21 2QX Knaphill
    Surrey
    United KingdomBritish54976140002
    BATE, Dennis
    109 Carmill Road
    Billinge
    WN5 7TY Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    109 Carmill Road
    Billinge
    WN5 7TY Wigan
    Lancashire
    British28569910001
    BATE, Dennis
    109 Carmill Road
    Billinge
    WN5 7TY Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    109 Carmill Road
    Billinge
    WN5 7TY Wigan
    Lancashire
    British28569910001
    CHALMERS, Douglas Charles Robert
    Gubblecote Farm Barn
    HP23 4QG Gubblecote
    Hertfordshire
    Amministratore
    Gubblecote Farm Barn
    HP23 4QG Gubblecote
    Hertfordshire
    EnglandBritish152499570001
    CHESSELLS, Arthur David, Sir
    Oakleigh Catts Hill
    TN6 3NQ Mark Cross
    East Sussex
    Amministratore
    Oakleigh Catts Hill
    TN6 3NQ Mark Cross
    East Sussex
    EnglandBritish39000870003
    DARLING, Andrew David
    4 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    West Lothian
    Amministratore
    4 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    West Lothian
    British73218540001
    DAVIS, Michael Edward
    Guy Lane
    CH3 7RZ Waverton
    Stapleford House
    Chester
    Amministratore
    Guy Lane
    CH3 7RZ Waverton
    Stapleford House
    Chester
    United KingdomBritish131261410001
    DAVIS, Michael Edward
    Kingswater Stickling Green
    Clavering
    CB11 4QX Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Kingswater Stickling Green
    Clavering
    CB11 4QX Saffron Walden
    Essex
    British49577090002
    DICKIE, Timothy John
    51 Summerside Place
    EH6 4NY Edinburgh
    Amministratore
    51 Summerside Place
    EH6 4NY Edinburgh
    British107164130002
    GANDER, Alan Keith
    54 Flora Thompson Drive
    MK16 8ST Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Amministratore
    54 Flora Thompson Drive
    MK16 8ST Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    British73248930001
    GILLESPIE, Kenneth William
    Regency House
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    Suite 3
    Amministratore
    Regency House
    91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    Suite 3
    ScotlandBritish105139700001
    GRANT, Philip Robert
    40 Lumsdaine Drive
    KY11 9YU Dalgety Bay
    Fife
    Amministratore
    40 Lumsdaine Drive
    KY11 9YU Dalgety Bay
    Fife
    British76673520001
    GRANT, Stewart Chalmers
    Chester Road
    HA6 1BQ Northwood
    20
    Middlesex
    Amministratore
    Chester Road
    HA6 1BQ Northwood
    20
    Middlesex
    United KingdomBritish206362380001
    GRANT, Stewart Chalmers
    Chester Road
    HA6 1BQ Northwood
    20
    Middlesex
    Amministratore
    Chester Road
    HA6 1BQ Northwood
    20
    Middlesex
    United KingdomBritish206362380001
    HOCKADAY, Stephen
    33a Arterberry Road
    SW20 8AG London
    Amministratore
    33a Arterberry Road
    SW20 8AG London
    EnglandBritish101894100001
    HOCKADAY, Stephen
    33a Arterberry Road
    SW20 8AG London
    Amministratore
    33a Arterberry Road
    SW20 8AG London
    EnglandBritish101894100001
    JACKSON, Gregor Scott
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    Amministratore
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    EnglandBritish191227420001
    LAYTON, Matthew Robert
    Nutwood House
    Wormley West End
    EN10 7QN Broxbourne
    Hertfordshire
    Amministratore
    Nutwood House
    Wormley West End
    EN10 7QN Broxbourne
    Hertfordshire
    British98832270001
    MILLSOM, Barry Paul
    3rd Floor The Venus
    1 Old Park Lane
    M41 7HG Trafford
    Manchester
    Amministratore
    3rd Floor The Venus
    1 Old Park Lane
    M41 7HG Trafford
    Manchester
    EnglandBritish156461120001
    MURPHY, Helen Mary
    3rd Floor The Venus
    1 Old Park Lane
    M41 7HG Trafford
    Manchester
    Amministratore
    3rd Floor The Venus
    1 Old Park Lane
    M41 7HG Trafford
    Manchester
    EnglandIrish156461710001
    NEVILLE, Gary Arthur
    3rd Floor The Venus
    1 Old Park Lane
    M41 7HG Trafford
    Manchester
    Amministratore
    3rd Floor The Venus
    1 Old Park Lane
    M41 7HG Trafford
    Manchester
    EnglandBritish156463000001
    PERRY, David Keith
    Saint Leonards Road
    KT6 4DE Surbiton
    10
    Surrey
    Amministratore
    Saint Leonards Road
    KT6 4DE Surbiton
    10
    Surrey
    EnglandBritish71558970002
    POTGIETER, Johan Hendrik
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    Amministratore
    3rd Floor
    3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Ltd
    England
    EnglandSouth African173393140001
    POTTS, Roger Harold
    3rd Floor The Venus
    1 Old Park Lane
    M41 7HG Trafford
    Manchester
    Amministratore
    3rd Floor The Venus
    1 Old Park Lane
    M41 7HG Trafford
    Manchester
    United KingdomBritish111244220001
    POWLING, David Alan
    55 Calder Avenue
    AL9 7AH Brookmans Park
    Hertfordshire
    Amministratore
    55 Calder Avenue
    AL9 7AH Brookmans Park
    Hertfordshire
    United KingdomBritish94649360001
    PRESCOT, Julia Elizabeth
    130 Thurleigh Road
    SW12 8TU London
    Amministratore
    130 Thurleigh Road
    SW12 8TU London
    British75494820004

    Chi sono le persone con controllo significativo di HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Hexham General Hospital Spc Holdings Ltd
    Towers Business Park, Wilmslow Road
    M20 2YY Manchester
    Albany Spc Services Ltd, Adamson House
    England
    10 set 2016
    Towers Business Park, Wilmslow Road
    M20 2YY Manchester
    Albany Spc Services Ltd, Adamson House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione4108766
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental borrower debenture
    Creato il 27 lug 2006
    Consegnato il 09 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property t/no ND14211 k/a phase 1, hexham general hospital being land to the north east of maidens walk, hexham and all l/h property t/no ND142520 k/a phase 2, hexham general hospital being land to the north east of maidens walk, hexham. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Creditors(The Security Trustee)
    Transazioni
    • 09 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Property debenture
    Creato il 19 mag 2005
    Consegnato il 08 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/Hold land to the north east of maiden's walk,hexham,forming phase 1,hexham general hospital; t/nos ND108776 and ND112511; l/hold property known as phase 2 at hexham general hospital,ND112511;all right,title and interest in and to under the properties and all monies payable thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A fixed and floating charge debenture
    Creato il 27 apr 2001
    Consegnato il 10 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies debts and liabilities owing or incurred by the company to any secured creditor under or in connection with any secured finance document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Creditors
    Transazioni
    • 10 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    HEXHAM GENERAL HOSPITAL SPC LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 feb 2018Inizio della liquidazione
    19 apr 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Granville Firmin
    Suite 3 Regency House 91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    East Sussex
    Praticante
    Suite 3 Regency House 91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    East Sussex
    Richard Dixon Fleming
    Suite 3 Regency House 91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    East Sussex
    Praticante
    Suite 3 Regency House 91 Western Road
    BN1 2NW Brighton
    East Sussex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0