WHITWORTHS GROUP LIMITED

WHITWORTHS GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWHITWORTHS GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04131087
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WHITWORTHS GROUP LIMITED?

    • Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. (10890) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova WHITWORTHS GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Fti Consulting Llp
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WHITWORTHS GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SECKLOE 58 LIMITED27 dic 200027 dic 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di WHITWORTHS GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 mag 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per WHITWORTHS GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    17 pagineLIQ14

    Cessazione della carica di Stuart Jonathan Lowe come amministratore in data 23 apr 2018

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Orchard House, Irthlingborough Wellingborough Northamptonshire NN9 5DB a C/O Fti Consulting Llp 200 Aldersgate Street London EC1A 4HD in data 08 ago 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 19 lug 2017

    LRESEX

    Dichiarazione delle attività

    10 pagineLIQ02

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 apr 2016 al 31 ott 2016

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr Stuart Jonathan Lowe come amministratore in data 18 gen 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Dylan Unsworth come amministratore in data 26 gen 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Andrew Utting come amministratore in data 11 nov 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mark Fairweather come amministratore in data 23 dic 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 02 mag 2015

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 gen 2016

    Stato del capitale al 18 gen 2016

    • Capitale: GBP 358,362
    SH01

    Bilancio redatto al 03 mag 2014

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 gen 2015

    Stato del capitale al 16 gen 2015

    • Capitale: GBP 358,362
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Peter Andrew Utting il 16 ago 2013

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Colin Stephens come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 27 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 gen 2014

    Stato del capitale al 15 gen 2014

    • Capitale: GBP 358,362
    SH01

    Bilancio redatto al 27 apr 2013

    14 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Emw Seebeck House 1 Seebeck Place, Knowlhill Milton Keynes Buckinghamshire MK5 8FR United Kingdom

    1 pagineAD02

    Nomina di Peter Dylan Unsworth come amministratore

    2 pagineAP01

    Iscrizione dell'ipoteca 041310870006

    35 pagineMR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    37 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Re deletion of mems re sect 28 ca 2006 10/09/2013
    RES13
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di WHITWORTHS GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JARMAN, Daniel
    Wellingborough Road
    NN9 5DB Irthlingborough
    Orchard House
    Nothamptonshire
    United Kingdom
    Segretario
    Wellingborough Road
    NN9 5DB Irthlingborough
    Orchard House
    Nothamptonshire
    United Kingdom
    165072640001
    FAIRWEATHER, Mark Robert
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    C/O Fti Consulting Llp
    Amministratore
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    C/O Fti Consulting Llp
    EnglandBritish208083400001
    CHAMBERS, Christopher James
    Irthlingborough
    NN9 5DB Wellingborough
    Orchard House
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Segretario
    Irthlingborough
    NN9 5DB Wellingborough
    Orchard House
    Northamptonshire
    United Kingdom
    147427370001
    OAKLEY, Christopher Richard
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    British124625030001
    PARTRIDGE, Charles Edward
    24 Ashpole Spinney
    NN4 9QB Northampton
    Segretario
    24 Ashpole Spinney
    NN4 9QB Northampton
    British77450510002
    ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Segretario nominato
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004530001
    EMW SECRETARIES LIMITED
    Seckloe House
    101 North 13th Street
    MK9 3NX Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    Seckloe House
    101 North 13th Street
    MK9 3NX Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    93910510001
    ANDREW, Vincent Leo
    Copperfields
    1 Hamlet Green, Dallington
    NN5 7AR Northampton
    Amministratore
    Copperfields
    1 Hamlet Green, Dallington
    NN5 7AR Northampton
    United KingdomBritish116947660003
    BARBOUR SMITH, James Kenneth Alexander
    The Square House
    Latchmoor Grove
    SL9 8LN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Square House
    Latchmoor Grove
    SL9 8LN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British80175630001
    CARTER, Michael William
    Vine Cottage
    Pinfold Lane
    RG8 8SH Ashampstead
    Berkshire
    Amministratore
    Vine Cottage
    Pinfold Lane
    RG8 8SH Ashampstead
    Berkshire
    British114525240001
    CASLIN, James
    43 Rolleston Drive
    CH45 6XE Wallasey
    Merseyside
    Amministratore
    43 Rolleston Drive
    CH45 6XE Wallasey
    Merseyside
    British116947340001
    CHAMBERS, Christopher James
    Irthlingborough
    NN9 5DB Wellingborough
    Orchard House
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Irthlingborough
    NN9 5DB Wellingborough
    Orchard House
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish147427330001
    INCHLEY, Simon Nicholas
    The Farmhouse, Top Yard Farm
    Burnmill Road, Great Bowden
    LE16 7JB Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    The Farmhouse, Top Yard Farm
    Burnmill Road, Great Bowden
    LE16 7JB Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish64345880002
    LOWE, Stuart Jonathan
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    C/O Fti Consulting Llp
    Amministratore
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    C/O Fti Consulting Llp
    United KingdomBritish30980880002
    NAYLOR, Peter David
    31 Barlows Road
    Harborne
    B15 2PN Birmingham
    Amministratore
    31 Barlows Road
    Harborne
    B15 2PN Birmingham
    British73589160004
    OAKLEY, Christopher Richard
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish124625030001
    PARTRIDGE, Charles Edward
    24 Ashpole Spinney
    NN4 9QB Northampton
    Amministratore
    24 Ashpole Spinney
    NN4 9QB Northampton
    United KingdomBritish77450510002
    PRATT, David Andrew
    The Former Vicarage
    41 Main Street
    CB5 9AB Stow Cum Quy
    Cambridgeshire
    Amministratore
    The Former Vicarage
    41 Main Street
    CB5 9AB Stow Cum Quy
    Cambridgeshire
    British61204820002
    ROME, Martin Leslie
    3 Lowswood Close
    HA6 2XE Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    3 Lowswood Close
    HA6 2XE Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish56407850003
    SHEARS, Tim
    The Dog House
    12 Dawson Court, Station Road
    LE15 6SD Oakham
    Rutland
    Amministratore
    The Dog House
    12 Dawson Court, Station Road
    LE15 6SD Oakham
    Rutland
    British116796720002
    SMITH, David Jervis
    22 Audley Close
    LE16 8ER Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    22 Audley Close
    LE16 8ER Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish116796520002
    STEPHENS, Colin Alan
    Orchard Road
    SL4 2RZ Old Windsor
    12c
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Orchard Road
    SL4 2RZ Old Windsor
    12c
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish129694970001
    UNSWORTH, Peter Dylan
    Irthlingborough
    NN9 5DB Wellingborough
    Orchard House
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Irthlingborough
    NN9 5DB Wellingborough
    Orchard House
    Northamptonshire
    United Kingdom
    EnglandBritish32904400004
    UTTING, Peter Andrew
    Orchard House, Irthlingborough
    Wellingborough
    NN9 5DB Northamptonshire
    Amministratore
    Orchard House, Irthlingborough
    Wellingborough
    NN9 5DB Northamptonshire
    United KingdomBritish129694830001
    VICARY, Gary Kevin
    Desborough Manorial Road
    Parkgate
    CH64 6QN Neston
    Wirral
    Amministratore
    Desborough Manorial Road
    Parkgate
    CH64 6QN Neston
    Wirral
    British18943850005
    WOODHEAD, Ian
    Manor House
    Church Lane, Brigsley
    DN37 0RH Grimsby
    South Humberside
    Amministratore
    Manor House
    Church Lane, Brigsley
    DN37 0RH Grimsby
    South Humberside
    EnglandBritish73390240001
    ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004520001
    EMW DIRECTORS LIMITED
    Seckloe House
    101 North 13th Street
    MK9 3NX Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Seckloe House
    101 North 13th Street
    MK9 3NX Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    97336730001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WHITWORTHS GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Irthlingborough
    NN9 5DB Wellingborough
    Orchard House
    Northamptonshire
    England
    06 apr 2016
    Irthlingborough
    NN9 5DB Wellingborough
    Orchard House
    Northamptonshire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05385634
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WHITWORTHS GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 10 set 2013
    Consegnato il 24 set 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Trade marks tm number UK00002383797 jurisdiction UK, tm number 164539 jurisdiction turkey see image for full details. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 24 set 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    An omnibus letter of set-off
    Creato il 01 nov 2007
    Consegnato il 02 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession to a debenture dated 26 january 2007 and
    Creato il 26 gen 2007
    Consegnato il 02 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession
    Creato il 30 ott 2006
    Consegnato il 15 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ecas S.A.R.L (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 15 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage of life and total and permanent disability policies
    Creato il 10 apr 2001
    Consegnato il 18 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The life and total permanent disability policies in respect of gary vicary and david pratt.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 apr 2001
    Consegnato il 18 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WHITWORTHS GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 lug 2017Inizio della liquidazione
    24 dic 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Johnson
    200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    Praticante
    200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    Lisa Jane Rickelton
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    Praticante
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0