CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED

CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04132389
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    Bedfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) PLC01 giu 200301 giu 2003
    L.I. HOLDINGS (UK) PLC12 dic 200112 dic 2001
    LI HOLDINGS (UK) LIMITED26 feb 200126 feb 2001
    ALNERY NO. 2125 LIMITED29 dic 200029 dic 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 dic 2011

    8 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Pellipar House 1st Floor 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 gen 2012

    Stato del capitale al 06 gen 2012

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    10 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 201 Bishopsgate London EC2M 3AF United Kingdom

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    9 pagineAA

    Certificato di ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata

    1 pagineCERT10

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    9 pagineMAR

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di ri-registrazione

    RES02

    Riregistrazione da società pubblica a società a responsabilità limitata privata

    2 pagineRR02

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Burchall il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Rebecca Jane Watson il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Rebecca Jane Watson il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    10 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Other133821050001
    BURCHALL, Andrew Jeremy
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish69904570002
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish70686070002
    OSBORNE, Philip Thomas
    1715 Bella Vista
    PO BOX 1764
    FOREIGN Belize City
    Belize
    Segretario
    1715 Bella Vista
    PO BOX 1764
    FOREIGN Belize City
    Belize
    British76955710002
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    Segretario
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    British38346120001
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    Segretario
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    British57975730001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Segretario nominato
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    BRADFORD, Richard James
    Holcombe House
    Olney Road
    MK46 5BX Emberton
    Buckinghamshire
    Bucks
    Amministratore
    Holcombe House
    Olney Road
    MK46 5BX Emberton
    Buckinghamshire
    Bucks
    United KingdomBritish72452740004
    CHOLERTON, John David
    3 Bryanston Avenue
    Whitton
    TW2 6HP Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    3 Bryanston Avenue
    Whitton
    TW2 6HP Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish9497220001
    COATES, Jeremy William
    62 The Grove
    MK40 3JN Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    62 The Grove
    MK40 3JN Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish58806030001
    DOYLE, Desmond Mark Christopher
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    Amministratore
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    EnglandBritish266121440001
    LAWRIE, Stuart
    Magpie Cottage
    Retford Road
    S81 8ER Blyth
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Magpie Cottage
    Retford Road
    S81 8ER Blyth
    Nottinghamshire
    British84516540001
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    EnglandBritish38346120001
    PUGH, Ian Russel
    Albury Lodge Warren Drive
    Kingswood
    KT20 6PZ Tadworth
    Surrey
    Amministratore
    Albury Lodge Warren Drive
    Kingswood
    KT20 6PZ Tadworth
    Surrey
    United KingdomBritish61327530003
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritish57975730001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Amministratore delegato nominato
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Amministratore delegato nominato
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002910001
    SOUTHTOWN LIMITED
    Craigmuir Chambers
    PO BOX 71
    Roadtown
    Tortola
    Br Virgin Islands
    Amministratore
    Craigmuir Chambers
    PO BOX 71
    Roadtown
    Tortola
    Br Virgin Islands
    70598540001

    CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 06 mag 2008
    Consegnato il 23 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or to any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trusgtee (C.I.) Limited (the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 23 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 mag 2008
    Consegnato il 17 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from impellam group PLC, the original security obligors and any person which grants a security interest to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    A deed of charge and memorandum of deposit between the depositors and the bank of nova scotia as agent and security trustee (the"security trustee") for the secured parties (as defined)
    Creato il 12 mar 2001
    Consegnato il 30 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations of the depositors to the chargee under or in respect of the credit agreement the guarantees and all other loan documents to which they are a party and all liabilities of each depositor under the deed (in each case whether in respect of principal interest fees taxes costs expenses or indemnities and whether present or future or actual or contingent) all terms as defined
    Brevi particolari
    All the undertaking and all the assets rights income goodwill of the chargor both present and future see the mortgage charge document or full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of Nova Scotia as Agent and Security Trustee for the Lenders
    Transazioni
    • 30 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of floating charge
    Creato il 01 mar 2001
    Consegnato il 20 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or inrespect of the credit agreement the guarantee and other loan documents (all as defined)
    Brevi particolari
    Floating charge all the undertaking and all the assets rights income and goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Nova Scotia
    Transazioni
    • 20 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0