ACORN OIL & GAS LIMITED

ACORN OIL & GAS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàACORN OIL & GAS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04132465
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ACORN OIL & GAS LIMITED?

    • Estrazione di petrolio greggio (06100) / Attività estrattive

    Dove si trova ACORN OIL & GAS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o PINNACLE ENERGY LIMITED
    Saxon House
    28 Castle Street
    GU1 3UW Guildford
    Surrey
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ACORN OIL & GAS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per ACORN OIL & GAS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A2CIETFU

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 gen 2013

    Stato del capitale al 17 gen 2013

    • Capitale: GBP 275,002
    SH01
    X209LO00

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA
    A1DV2DWJ

    Cessazione della carica di Simon William Caines Eyers come amministratore in data 14 mar 2012

    1 pagineTM01
    X1BVS5UP

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    X10PFWJS

    Indirizzo della sede legale modificato da Ash House Fairfield Avenue Staines Middlesex TW18 4AB in data 01 dic 2011

    1 pagineAD01
    XHOEUZOX

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA
    A4FC9XZA

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    2 pagineDS02
    A7FYJXS2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    AR2GYW2F

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    XN0QNRAY

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    20 pagineAA
    A10BYNU1

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    20 pagineAA
    LROEFHU4

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    X01AGGGK

    Dettagli del direttore cambiati per Jerome Halbout il 29 dic 2009

    2 pagineCH01
    X01AFGGJ

    legacy

    1 pagine288b
    XB05GD6C

    legacy

    6 pagine363a
    X1FJRC76

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    19 pagineAA
    L6BCB9TR

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    20 pagineAA
    LCX0F62H

    legacy

    1 pagine288b
    A0YLW5MG

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    2 pagine403b

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2005

    41 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ACORN OIL & GAS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GUNN, Peter Robert Francis
    9 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    9 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British109763710001
    HALBOUT, Jerome
    1 Bis Rue Dagorno
    FOREIGN Paris
    75012
    France
    Amministratore
    1 Bis Rue Dagorno
    FOREIGN Paris
    75012
    France
    FranceFrenchVenture Capitalist99362600001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Segretario nominato
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    FIELDS, Patricia
    6 Eghams Close
    HP9 1XN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    6 Eghams Close
    HP9 1XN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    AmericanCompany Secretary74001590001
    STEIN, Gordon Bowman
    35 Halepit Road
    KT23 4BS Great Bookham
    Surrey
    Segretario
    35 Halepit Road
    KT23 4BS Great Bookham
    Surrey
    BritishAccountant74991780002
    ARKLEY, Paul
    6 Eghams Close
    Knotty Green
    HP9 1XN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    6 Eghams Close
    Knotty Green
    HP9 1XN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishEngineer38929720002
    BUSHELL, Timothy Paul
    Pitch Green House
    Sandpit Lane
    HP27 9QQ Bledlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Pitch Green House
    Sandpit Lane
    HP27 9QQ Bledlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritishGeologist124313030001
    DWYER, Daniel James
    Fieldstock
    Vicarage Road
    DA5 2AW Bexley
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    Fieldstock
    Vicarage Road
    DA5 2AW Bexley
    Kent
    British900019460001
    EYERS, Simon William Caines
    7 Wilmington Square
    WC1X 0ES London
    Amministratore
    7 Wilmington Square
    WC1X 0ES London
    United KingdomBritishVenture Capitalist81009050001
    GLUYAS, Jonathan Gordon, Professor
    26 Woodlands Park
    Merrow
    GU1 2TJ Guildford
    Surrey
    Amministratore
    26 Woodlands Park
    Merrow
    GU1 2TJ Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishGeologist80474260001
    GLUYAS, Jonathan Gordon, Professor
    26 Woodlands Park
    Merrow
    GU1 2TJ Guildford
    Surrey
    Amministratore
    26 Woodlands Park
    Merrow
    GU1 2TJ Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishGeologist80474260001
    GLUYAS, Jonathan Gordon, Professor
    26 Woodlands Park
    Merrow
    GU1 2TJ Guildford
    Surrey
    Amministratore
    26 Woodlands Park
    Merrow
    GU1 2TJ Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishGeologist80474260001
    KIMBER, Terence Frank
    Oakhurst
    The Highlands
    KT24 5BQ East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Oakhurst
    The Highlands
    KT24 5BQ East Horsley
    Surrey
    United KingdomBritishC Eng160458280001
    MCALLISTER, Mark Francis
    9 Mansion Drive
    HP23 5BD Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 Mansion Drive
    HP23 5BD Tring
    Hertfordshire
    United KingdomBritishOil Industry Manager67898480002
    NORTON, Hugh Edward
    101 Portland Road
    W11 4LN London
    Amministratore
    101 Portland Road
    W11 4LN London
    BritishBusinessman210730008
    PONSONBY, Frederick Matthew Thomas, Lord
    23 Rosehill Road
    SW18 2NY London
    Amministratore
    23 Rosehill Road
    SW18 2NY London
    EnglandBritishDirector61174550002
    STEIN, Gordon Bowman
    35 Halepit Road
    KT23 4BS Great Bookham
    Surrey
    Amministratore
    35 Halepit Road
    KT23 4BS Great Bookham
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant74991780002
    WRIGHT, Christopher Alan, Dr
    Old Byways House
    Gravel Path
    HP4 2PS Berkhamstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    Old Byways House
    Gravel Path
    HP4 2PS Berkhamstead
    Hertfordshire
    BritishConsultant107937430001

    ACORN OIL & GAS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of deposits
    Creato il 21 mag 2007
    Consegnato il 24 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £1,400,000 credited to account designation 15638278 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over cash deposit
    Creato il 28 mar 2007
    Consegnato il 14 apr 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transazioni
    • 14 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge of deposit
    Creato il 14 nov 2005
    Consegnato il 02 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 140-18512437-01 (nxnfgjzy-usd-01) with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security over investments strip deed
    Creato il 05 nov 2005
    Consegnato il 23 nov 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    800,000 investment strips and any other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fairfield Energy Limited
    Transazioni
    • 23 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 26 ago 2005
    Consegnato il 09 set 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the property which is or may be from time to time comprised in the property and undertaking of the company.
    Persone aventi diritto
    • Sgam/4D Global Energy Development Capital Fund PLC
    Transazioni
    • 09 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Deed of guarantee and security
    Creato il 28 feb 2005
    Consegnato il 01 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee up to us$4,500,000 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the property from time to time comprises in the property and undertaking.
    Persone aventi diritto
    • Sgam/4D Global Energy Development Capital Fund PLC
    Transazioni
    • 01 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0