BLUE 8 TECHNOLOGIES LIMITED

BLUE 8 TECHNOLOGIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBLUE 8 TECHNOLOGIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04132471
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BLUE 8 TECHNOLOGIES LIMITED?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova BLUE 8 TECHNOLOGIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BLUE 8 TECHNOLOGIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GW 1212 LIMITED29 dic 200029 dic 2000

    Quali sono gli ultimi bilanci di BLUE 8 TECHNOLOGIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per BLUE 8 TECHNOLOGIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4NW a 15 Canada Square London E14 5GL in data 03 lug 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 giu 2019

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2018

    2 pagineAA

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2019 al 31 mar 2019

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 ago 2018

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen James Callaghan il 06 ago 2018

    2 pagineCH01

    Bilancio abbreviato redatto al 30 apr 2017, non revisionato

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 dic 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Coll come amministratore in data 06 dic 2016

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Mr Stephen James Callaghan come amministratore in data 10 ott 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David John Meaden come amministratore in data 10 ott 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 gen 2016

    Stato del capitale al 28 gen 2016

    • Capitale: GBP 35,507
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 feb 2015

    Stato del capitale al 06 feb 2015

    • Capitale: GBP 35,507
    SH01

    Chi sono gli amministratori di BLUE 8 TECHNOLOGIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector201347710052
    AMOS, David Stephen
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    Segretario
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    BritishDirector65186080003
    AUNGLES, Glenn
    11 Bridgford Road
    West Bridgford
    NG2 6AN Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    11 Bridgford Road
    West Bridgford
    NG2 6AN Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishFinance Director67690750001
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    51 The Avenue
    WD17 4NU Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    51 The Avenue
    WD17 4NU Watford
    Hertfordshire
    British75357260001
    MCLACHLAN, Iain
    High Banks
    Pailton Road
    CV23 0HQ Harborough Magna
    Warwickshire
    Segretario
    High Banks
    Pailton Road
    CV23 0HQ Harborough Magna
    Warwickshire
    BritishDirector87194100001
    NUNN, Carol Jayne
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British101872040001
    RICHARDSON, John David
    Peoplebuilding 2
    Peoplebuilding Estate Maylands
    HP2 4NW Avenue Hemel Hempstead
    Herts
    Segretario
    Peoplebuilding 2
    Peoplebuilding Estate Maylands
    HP2 4NW Avenue Hemel Hempstead
    Herts
    British128558470001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    GW SECRETARIES LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    93128710001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanDirector165900220001
    AMOS, David Stephen
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    BritishDirector65186080003
    AUNGLES, Glenn
    11 Bridgford Road
    West Bridgford
    NG2 6AN Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    11 Bridgford Road
    West Bridgford
    NG2 6AN Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishFinance Director67690750001
    BLACKHURST, Ian Robert
    5a Bute Drive
    BH23 5LE Highcliffe
    Dorset
    Amministratore
    5a Bute Drive
    BH23 5LE Highcliffe
    Dorset
    BritishSales Director75399750001
    BOLD, Stephen John
    28 Boundary Road
    NG2 7BZ West Bridgford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    28 Boundary Road
    NG2 7BZ West Bridgford
    Nottinghamshire
    BritishOperations Director75399610001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director237260100001
    KANTER, Ralph Thomas Ludwig
    Garden Flat
    17 Upper Park Road
    NW3 2UN London
    Amministratore
    Garden Flat
    17 Upper Park Road
    NW3 2UN London
    United KingdomBritishCompany Director124153720001
    MCLACHLAN, Iain
    High Banks
    Pailton Road
    CV23 0HQ Harborough Magna
    Warwickshire
    Amministratore
    High Banks
    Pailton Road
    CV23 0HQ Harborough Magna
    Warwickshire
    BritishCompany Director87194100001
    MEADEN, David John
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive193740420001
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector199843940001
    OTHACEHE, Laurent
    9 Parker Gardens
    Stapleford
    NG9 8QG Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    9 Parker Gardens
    Stapleford
    NG9 8QG Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomFrenchBusiness Development Director76247530001
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChief Executive66955690003
    TURNER, Mark Robert James
    The Rookery
    Bishopstone
    HP17 8SH Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Rookery
    Bishopstone
    HP17 8SH Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishPortfolio Manager101563880001
    WILLIAMSON, Ian
    8 Wentworth Close
    Kibworth
    LE8 0XB Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    8 Wentworth Close
    Kibworth
    LE8 0XB Leicester
    Leicestershire
    BritishManaging Director60920680003
    GW INCORPORATIONS LIMITED
    Windsor House
    3 Temple Row
    B2 5JR Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Windsor House
    3 Temple Row
    B2 5JR Birmingham
    West Midlands
    68279000001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BLUE 8 TECHNOLOGIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00968498
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BLUE 8 TECHNOLOGIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 25 apr 2005
    Consegnato il 10 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 10 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 26 mag 2004
    Consegnato il 15 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land; investments; plant and machinery; credit balances; book debts etc.; insurances; other contracts; intellectual property; miscellaneous; by way of floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 lug 2001
    Consegnato il 26 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £71,764.75 and all other monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with the rent deposit deed
    Brevi particolari
    All sums paid by the company into its deposit account at child & co, 1 fleet street, london, EC4Y 1BD, including the initial deposit.
    Persone aventi diritto
    • Business Homes B1 Limited
    Transazioni
    • 26 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 27 mar 2001
    Consegnato il 10 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policy being: insurer: alder life, policy number: 790/aungles-001, life assured: glen aungles, sum assured: £100,000, term of cover: five years and all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it (including sundry conditions, provisions and declarations) and the company's whole right, title and interest present and future in such policy.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 27 mar 2001
    Consegnato il 10 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policy being: insurer: alder life, policy number: KPR00072/blackhurst I-001, life assured: ian blackhurst, sum assured: £150,000, term of cover: five years and all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it (including sundry conditions, provisions and declarations) and the company's whole right, title and interest present and future in such policy.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 27 mar 2001
    Consegnato il 10 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policy being: insurer: alder life, policy number: 791/bolds-001, life assured: stephen bold, sum assured: £100,000, term of cover: five years and all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it (including sundry conditions, provisions and declarations) and the company's whole right, title and interest present and future in such policy.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 27 mar 2001
    Consegnato il 10 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policy being: insurer: alder life, policy number: KRP00073/othacehel-001, life assured: laurent orthacehe, sum assured: £150,000, term of cover: five years and all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it (including sundry conditions, provisions and declarations) and the company's whole right, title and interest present and future in such policy.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 27 mar 2001
    Consegnato il 10 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policy being: insurer: standard life, policy number: X71319209, life assured: ian williamson, sum assured: £250,000, term of cover: five years and all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it (including sundry conditions, provisions and declarations) and the company's whole right, title and interest present and future in such policy.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 mar 2001
    Consegnato il 30 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BLUE 8 TECHNOLOGIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 giu 2019Inizio della liquidazione
    13 ago 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0